Buscador CIF Logo

Actos BORME Becquer Sociedad Anonima Hotelera

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Becquer Sociedad Anonima Hotelera

Actos BORME Becquer Sociedad Anonima Hotelera - A41027723

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Becquer Sociedad Anonima Hotelera con CIF A41027723

🔙 Perfil de Becquer Sociedad Anonima Hotelera
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Becquer Sociedad Anonima Hotelera

25 de Julio de 2023
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 6843 , F 201, S 8, H SE 8643, I/A 54 (18.07.23).

02 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 6843 , F 200, S 8, H SE 8643, I/A 53 (25.01.23).

01 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 6843 , F 200, S 8, H SE 8643, I/A 52 (24.01.23).

01 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: MANTERO DE MONTES MARIA LUISA;MANTERO DE MONTES MARIA LUISA;MANTERO DEMONTES MARIA LUISA. Otros conceptos: Se revoca el poder no inscrito conferido a favor de DOÑA MARIA LUISA MANTERO DEMONTES, en virtu de escritura otorgada ante el Notario de Sevilla don Juan Butiña Agusti, el día veinticinco de junio de dos mil trece,bajo el número 968 de Protocolo. Datos registrales. T 6843 , F 200, S 8, H SE 8643, I/A 51 (22.02.22).

13 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GUTIERREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 6843 , F 198, S 8, H SE 8643, I/A 50(29.09.21).

04 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Vicesecret.: MARTINEZ AREVALO RAMIRO. Con.Delegado:MARTINEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL. Secretario: GUERRERO MARTINEZ MARIA JOSE. Nombramientos. Presidente: MARTINEZALVAREZ LUIS MIGUEL. Apo.Manc.: GUERRERO MARTINEZ MARIA JOSE;MARTINEZ ALVAREZ SILVIA INMACULADA.Secretario: MARTINEZ AREVALO RAMIRO. Reelecciones. Consejero: MARTINEZ AREVALO RAMIRO;GUERRERO MARTINEZMARIA JOSE;MARTINEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL;MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON;MARTINEZ ALVAREZ SILVIAINMACULADA. Modificaciones estatutarias. 26. RETRIBUCION.-. Datos registrales. T 6843 , F 196, S 8, H SE 8643, I/A 49(28.09.21).

18 de Agosto de 2021
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Otros conceptos: Se hace constar: Que el auditor que consta inscrito es"AUREN HOLDING SP, SLP", la cual segregó parte de su patrimonio, consistente en la prestación de servicios de auditorías a, entreotra, la firma auditora "AUREN AUDITORES SP, SLP". Datos registrales. T 6843 , F 196, S 8, H SE 8643, I/A 48 (11.08.21).

02 de Julio de 2021
Nombramientos. Auditor: AUREN HOLDING SP SLP. Datos registrales. T 6843 , F 195, S 8, H SE 8643, I/A 47 (24.06.21).

04 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GUTIERREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 5745 , F 40, S 8, H SE 8643, I/A 46 (8.04.20).

21 de Agosto de 2018
Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-.Otros conceptos: Se ratifica el nombramiento por cooptación de Doña Silvia Inmaculada Martinez Alvarez realizado en la junta defecha 22 de mayo de 2018. Ampliacion del objeto social. La prestación de servicios corporativos, de administración, gestión,asesoramiento y mantenimiento, así como de cualesquiera otros servicios relacionados con la explotación de hoteles, moteles ycafeterías, en favor de otras empresas. Datos registrales. T 5745 , F 39, S 8, H SE 8643, I/A 44 ( 3.08.18).

14 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ROJAS MARCOS ANDREA. Datos registrales. T 5745 , F 39, S 8, H SE 8643, I/A 45 (7.08.18).

10 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ FONSECA JUAN RAMON. Presidente: MARTINEZ FONSECA JUAN RAMON.Vicesecret.: MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ALVAREZ SILVIA INMACULADA.Presidente: MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Vicesecret.: MARTINEZ AREVALO RAMIRO. Datos registrales. T 5745 , F 38, S8, H SE 8643, I/A 43 ( 2.07.18).

23 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5745 , F 38, S 8, H SE 8643, I/A 42 (16.08.17).

18 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: MANTERO DE MONTES MARIA LUISA. Datos registrales. T 5745 , F 37, S 8, H SE 8643, I/A 41 (7.08.17).

12 de Junio de 2017
Reelecciones. Consejero: MARTINEZ AREVALO RAMIRO;MARTINEZ FONSECA JUAN RAMON;GUERRERO MARTINEZ MARIAJOSE;MARTINEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL. Con.Delegado: MARTINEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL. Consejero: MARTINEZ ALVAREZJUAN RAMON. Presidente: MARTINEZ FONSECA JUAN RAMON. Secretario: GUERRERO MARTINEZ MARIA JOSE. Vicesecret.:MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 5745 , F 37, S 8, H SE 8643, I/A 40 ( 5.06.17).

19 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ FONSECA JUAN RAMON. Datos registrales. T 5745 , F 36, S 8, H SE 8643, I/A 39(12.01.17).

16 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5745 , F 35, S 8, H SE 8643, I/A 37 ( 2.11.16).

03 de Febrero de 2016
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5745 , F 35, S 8, H SE 8643, I/A 36 (27.01.16).

12 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Nombramientos. Secretario: GUERRERO MARTINEZMARIA JOSE. Vicesecret.: MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Modificaciones estatutarias. se modifican los artículos 5bis, 8º,9º, 10 15 17 , 19ºbis, 22ºbis, 23 25 26 , 27ºy 36 de los Estatutos Sociales,. 8. Régimen de transmision intervivos. Datos registrales. T5745 , F 32, S 8, H SE 8643, I/A 34 (29.05.15).

Otros conceptos: Se delegan nuevas facultades al consejero delegado D. Luis Miguel Martínez Alvarez.- Datos registrales. T 5745, F 32, S 8, H SE 8643, I/A 35 ( 5.06.15).

27 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: MANTERO DE MONTES MARIA LUISA. Datos registrales. T 5745 , F 31, S 8, H SE 8643, I/A 33(18.05.15).

16 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ ALVAREZ SERGIO. Otros conceptos: REVOCADOS los poderes conferidos a don SergioMartínez Alvarez mediante escritura otorgada en Sevilla, el día 25 de junio de 2.013, ante el Notario don Juan Butiña Agustí, número969 de su protocolo, los cuales NO CONSTAN INSCRITOS EN ESTE REGISTRO.- Datos registrales. T 5745 , F 31, S 8, H SE 8643,I/A 32 ( 9.12.14).

25 de Septiembre de 2013
Otros conceptos: Revoca las facultades que le fueron conferidas al Consejero Delegado, Don Luis Miguel Martínez Alvarez por lainscripción 29& y le delega nuevas facultades.- Datos registrales. T 3108 , F 114, S 8, H SE 8643, I/A 31 (18.09.13).

27 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ FONSECA MARIA TERESA. Secretario: MARTINEZ FONSECA JUAN RAMON.Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Presidente: MARTINEZ FONSECA JUAN RAMON. Secretario:MARTINEZ ALVAREZ JUAN RAMON. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 16º,19º, 23º Y 30º DE LOSESTATUTOS SOCIALES.- . Datos registrales. T 3108 , F 113, S 8, H SE 8643, I/A 30 (18.02.13).

23 de Octubre de 2012
Reelecciones. Consejero: JUAN RAMON MARTINEZ FONSECA;GUERRERO MARTINEZ MARIA JOSE;MARTINEZ FONSECAMARIA TERESA. Presidente: MARTINEZ FONSECA MARIA TERESA. Secretario: JUAN RAMON MARTINEZ FONSECA. Consejero:LUIS MIGUEL MARTINEZ ALVAREZ. Con.Delegado: LUIS MIGUEL MARTINEZ ALVAREZ. Datos registrales. T 3108 , F 112, S 8, HSE 8643, I/A 29 ( 9.10.12).

28 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 3108 , F 112, S 8, H SE 8643, I/A 28 (16.08.12).

15 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ FONSECA MANUEL. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ AREVALO RAMIRO.Datos registrales. T 3108 , F 111, S 8, H SE 8643, I/A 27 ( 2.03.12).

09 de Enero de 2012
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 2º: Objeto social.-. Ampliacion del objeto social. Generaciónde energía eléctrica en régimen especial y su cesión y/o venta en los términos establecidos por la normativa vigente.- Datosregistrales. T 3108 , F 111, S 8, H SE 8643, I/A 26 (15.12.11).

22 de Septiembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ MARTINEZ MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: MANTERO DE MONTES MARIA LUISA.Datos registrales. T 3108 , F 110, S 8, H SE 8643, I/A 25 (10.09.10).

29 de Octubre de 2009
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 3108 , F 109, S 8, H SE 8643, I/A 24 (14.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información