Buscador CIF Logo

Actos BORME Bekaert Iberica Holding Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bekaert Iberica Holding Sl

Actos BORME Bekaert Iberica Holding Sl - B09333444

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Bekaert Iberica Holding Sl con CIF B09333444

馃敊 Perfil de Bekaert Iberica Holding Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Bekaert Iberica Holding Sl

19 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ PASCUAL GORKA. Datos registrales. T 811, L 602, F 165, S 8, H BU 6065, I/A 54 (13.10.23).

10 de Agosto de 2023
Reelecciones. Presidente: M. GROOTHAERT KOEN ERIK. Consejero: M. GROOTHAERT KOEN ERIK;LUTGARD P.HOUVENAGHEL ANN. Datos registrales. T 744, L 535, F 16, S 8, H BU 6065, I/A 52 ( 4.08.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CHRISTIAN MARCEL LESSCHAEVE ARNAUD. Nombramientos. Consejero: HONGYAN ANNIEXU. Datos registrales. T 744, L 535, F 16, S 8, H BU 6065, I/A 53 ( 4.08.23).

30 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES ESPOLIO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 744, L 535, F 16, S 8, H BU 6065, I/A 51(23.12.22).

31 de Agosto de 2022
Reelecciones. Consejero: CHRISTIAN MARCEL LESSCHAEVE ARNAUD. Datos registrales. T 744, L 535, F 15, S 8, H BU 6065,I/A 50 (25.08.22).

18 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOZEF LIPPENS YVAN. Presidente: JOZEF LIPPENS YVAN. Nombramientos. Consejero: M.GROOTHAERT KOEN ERIK. Presidente: M. GROOTHAERT KOEN ERIK. Datos registrales. T 744, L 535, F 15, S 8, H BU 6065, I/A49 (12.02.21).

03 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: P. SCHEERS BRAM WIM. Nombramientos. Consejero: LUTGARD P. HOUVENAGHEL ANN.Datos registrales. T 744, L 535, F 14, S 8, H BU 6065, I/A 48 (26.02.20).

06 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: LARMUSEAU LIEVEN. Nombramientos. Consejero: CHRISTIAN MARCEL LESSCHAEVEARNAUD. Datos registrales. T 744, L 535, F 14, S 8, H BU 6065, I/A 47 (30.10.19).

13 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: PICEU SERGE GERARD. Nombramientos. Consejero: P. SCHEERS BRAM WIM. Datosregistrales. T 744, L 535, F 13, S 8, H BU 6065, I/A 45 ( 7.05.19).

Revocaciones. Apo.Manc.: URRETA MARTINEZ PEDRO. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datos registrales. T 744,L 535, F 13, S 8, H BU 6065, I/A 46 ( 7.05.19).

27 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALISKAN MEMET METIN. Secretario: PICEU SERGE GERARD. Presidente: CALISKAN MEMETMETIN. Nombramientos. SecreNoConsj: LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Consejero: JOZEF LIPPENS YVAN. Presidente: JOZEFLIPPENS YVAN. Datos registrales. T 671, L 462, F 35, S 8, H BU 6065, I/A 41 (21.03.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALISKAN MEMET METIN. Datos registrales. T 744, L 535, F 11, S 8, H BU 6065, I/A 42 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: CASTILLA ESTEBANEZ SARA. Datos registrales. T 744, L 535, F 12, S 8, H BU 6065, I/A 43(21.03.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: CASTILLA ESTEBANEZ SARA. Datos registrales. T 744, L 535, F 13, S 8, H BU 6065, I/A 44 (21.03.18).

24 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE. Consejero: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE. Nombramientos.Consejero: PICEAU SERGE GERARD. Secretario: PICEAU SERGE GERARD. Modificaciones estatutarias. Articulo 27潞.- Losmiembros del Consejo de Administraci贸n podr谩n adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesi贸n, siempre que en cada caso, ninguno delos consejeros se oponga a este procedimieto. . Datos registrales. T 671, L 462, F 34, S 8, H BU 6065, I/A 40 (17.08.17).

31 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: CALISKAN MEMET METIN. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: HUMBLETBRUNO;VROMANT FRANK. Presidente: VROMANT FRANK. Nombramientos. Consejero: CALISKAN MEMET METIN. Presidente:CALISKAN MEMET METIN. Secretario: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE. Consejero: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE.Reelecciones. Consejero: LARMUSEAU LIEVEN. Datos registrales. T 671, L 462, F 33, S 8, H BU 6065, I/A 39 (25.10.16).

16 de Septiembre de 2015
Modificaciones estatutarias. 25. Se regula la asistencia a las reuniones del Consejo por medios telem谩ticos. . Datos registrales. T671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 37 ( 8.09.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: VELGE HENRI JEAN. Datos registrales. T 671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 38 ( 8.09.15).

23 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE GRAEVE ALBRECHT. Datos registrales. T 671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 36 (16.07.14).

10 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: DE GRAEVE ALBRECHT. Nombramientos. Presidente: VROMANT FRANK. Datos registrales. T671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 35 ( 4.06.14).

20 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: METIN CALISKAN MEMET. Apo.Manc.: MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL. Datos registrales.T 644, L 435, F 23, S 8, H BU 6065, I/A 33 (14.11.13).

Ceses/Dimisiones. Secretario: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Revocaciones. Apo.Sol.: CHAVES MIRANDA ROGERIO.Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Nombramientos. Secretario: CALISKAN MEMET METIN. Apo.Sol.: MONASTERIOLOPEZ MARIA ISABEL;LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Datos registrales. T 644, L 435, F 24, S 8, H BU 6065, I/A 34 (14.11.13).

29 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Datos registrales. T 644, L 435, F 23, S 8, H BU 6065, I/A 32(22.10.13).

31 de Julio de 2013
Reelecciones. Presidente: DE GRAEVE ALBRECHT. Consejero: DE GRAEVE ALBRECHT;HENRI JEAN VELGE;BRUNOHUMBLET;LARMUSEAU LIEVEN;VROMANT FRANK Datos registrales. T 644, L 435, F 23, S 8, H BU 6065, I/A 31 (25.07.13).

22 de Agosto de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.790.140,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.107.140,00 Euros. Datos registrales. T 644, L 435, F22, S 8, H BU 6065, I/A 30 (10.08.12).

18 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: ROYO RODES JUAN LUIS. Nombramientos. Secretario: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datosregistrales. T 644, L 435, F 21, S 8, H BU 6065, I/A 28 ( 8.05.12).

Revocaciones. Apoderado: ROYO RODES JUAN LUIS. Apo.Manc.: ROYO RODES JUAN LUIS;ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO.Apoderado: ROYO RODES JUAN LUIS. Apo.Manc.: ROYO RODES JUAN LUIS;ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO. Apo.Man.Soli:LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Apo.Sol.: ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO;MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL;CHAVES MIRANDAROGERIO;MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL;LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Apo.Sol.: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datosregistrales. T 644, L 435, F 21, S 8, H BU 6065, I/A 29 ( 8.05.12).

19 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROELENS GEERT. Nombramientos. Consejero: VROMANT FRANK. Datos registrales. T 644, L435, F 21, S 8, H BU 6065, I/A 27 (10.01.12).

27 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 443, L 234, F 205, S 8, H BU 6065, I/A25 (14.04.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datos registrales. T 443, L 234, F 205, S 8, H BU 6065, I/A 26(14.04.11).

02 de Septiembre de 2010
Reelecciones. Presidente: ALBRECHT DE GRAEVE. Consejero: ALBRECHT DE GRAEVE;HENRI JEAN VELGE;BRUNOHUMBLET;ROELENS GEERT;LARMUSEAU LIEVEN Datos registrales. T 443, L 234, F 205, S 8, H BU 6065, I/A 24 (24.08.10).

16 de Abril de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: URRETA MARTINEZ PEDRO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Datosregistrales. T 443, L 234, F 204, S 8, H BU 6065, I/A 22 ( 3.04.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO. Datos registrales. T 443, L 234, F 204, S 8, H BU 6065, I/A 23 (3.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n