Actos BORME de Bekaert Iberica Holding Sl
19 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ PASCUAL GORKA. Datos registrales. T 811, L 602, F 165, S 8, H BU 6065, I/A 54 (13.10.23).
10 de Agosto de 2023Reelecciones. Presidente: M. GROOTHAERT KOEN ERIK. Consejero: M. GROOTHAERT KOEN ERIK;LUTGARD P.HOUVENAGHEL ANN. Datos registrales. T 744, L 535, F 16, S 8, H BU 6065, I/A 52 ( 4.08.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CHRISTIAN MARCEL LESSCHAEVE ARNAUD. Nombramientos. Consejero: HONGYAN ANNIEXU. Datos registrales. T 744, L 535, F 16, S 8, H BU 6065, I/A 53 ( 4.08.23).
30 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES ESPOLIO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 744, L 535, F 16, S 8, H BU 6065, I/A 51(23.12.22).
31 de Agosto de 2022Reelecciones. Consejero: CHRISTIAN MARCEL LESSCHAEVE ARNAUD. Datos registrales. T 744, L 535, F 15, S 8, H BU 6065,I/A 50 (25.08.22).
18 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: JOZEF LIPPENS YVAN. Presidente: JOZEF LIPPENS YVAN. Nombramientos. Consejero: M.GROOTHAERT KOEN ERIK. Presidente: M. GROOTHAERT KOEN ERIK. Datos registrales. T 744, L 535, F 15, S 8, H BU 6065, I/A49 (12.02.21).
03 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: P. SCHEERS BRAM WIM. Nombramientos. Consejero: LUTGARD P. HOUVENAGHEL ANN.Datos registrales. T 744, L 535, F 14, S 8, H BU 6065, I/A 48 (26.02.20).
06 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: LARMUSEAU LIEVEN. Nombramientos. Consejero: CHRISTIAN MARCEL LESSCHAEVEARNAUD. Datos registrales. T 744, L 535, F 14, S 8, H BU 6065, I/A 47 (30.10.19).
13 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: PICEU SERGE GERARD. Nombramientos. Consejero: P. SCHEERS BRAM WIM. Datosregistrales. T 744, L 535, F 13, S 8, H BU 6065, I/A 45 ( 7.05.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: URRETA MARTINEZ PEDRO. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datos registrales. T 744,L 535, F 13, S 8, H BU 6065, I/A 46 ( 7.05.19).
27 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CALISKAN MEMET METIN. Secretario: PICEU SERGE GERARD. Presidente: CALISKAN MEMETMETIN. Nombramientos. SecreNoConsj: LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Consejero: JOZEF LIPPENS YVAN. Presidente: JOZEFLIPPENS YVAN. Datos registrales. T 671, L 462, F 35, S 8, H BU 6065, I/A 41 (21.03.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALISKAN MEMET METIN. Datos registrales. T 744, L 535, F 11, S 8, H BU 6065, I/A 42 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: CASTILLA ESTEBANEZ SARA. Datos registrales. T 744, L 535, F 12, S 8, H BU 6065, I/A 43(21.03.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: CASTILLA ESTEBANEZ SARA. Datos registrales. T 744, L 535, F 13, S 8, H BU 6065, I/A 44 (21.03.18).
24 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE. Consejero: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE. Nombramientos.Consejero: PICEAU SERGE GERARD. Secretario: PICEAU SERGE GERARD. Modificaciones estatutarias. Articulo 27潞.- Losmiembros del Consejo de Administraci贸n podr谩n adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesi贸n, siempre que en cada caso, ninguno delos consejeros se oponga a este procedimieto. . Datos registrales. T 671, L 462, F 34, S 8, H BU 6065, I/A 40 (17.08.17).
31 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Secretario: CALISKAN MEMET METIN. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: HUMBLETBRUNO;VROMANT FRANK. Presidente: VROMANT FRANK. Nombramientos. Consejero: CALISKAN MEMET METIN. Presidente:CALISKAN MEMET METIN. Secretario: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE. Consejero: JOZEF DERAEVE KOEN ANDRE.Reelecciones. Consejero: LARMUSEAU LIEVEN. Datos registrales. T 671, L 462, F 33, S 8, H BU 6065, I/A 39 (25.10.16).
16 de Septiembre de 2015Modificaciones estatutarias. 25. Se regula la asistencia a las reuniones del Consejo por medios telem谩ticos. . Datos registrales. T671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 37 ( 8.09.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: VELGE HENRI JEAN. Datos registrales. T 671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 38 ( 8.09.15).
23 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DE GRAEVE ALBRECHT. Datos registrales. T 671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 36 (16.07.14).
10 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: DE GRAEVE ALBRECHT. Nombramientos. Presidente: VROMANT FRANK. Datos registrales. T671, L 462, F 32, S 8, H BU 6065, I/A 35 ( 4.06.14).
20 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: METIN CALISKAN MEMET. Apo.Manc.: MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL. Datos registrales.T 644, L 435, F 23, S 8, H BU 6065, I/A 33 (14.11.13).
Ceses/Dimisiones. Secretario: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Revocaciones. Apo.Sol.: CHAVES MIRANDA ROGERIO.Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Nombramientos. Secretario: CALISKAN MEMET METIN. Apo.Sol.: MONASTERIOLOPEZ MARIA ISABEL;LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Datos registrales. T 644, L 435, F 24, S 8, H BU 6065, I/A 34 (14.11.13).
29 de Octubre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Datos registrales. T 644, L 435, F 23, S 8, H BU 6065, I/A 32(22.10.13).
31 de Julio de 2013Reelecciones. Presidente: DE GRAEVE ALBRECHT. Consejero: DE GRAEVE ALBRECHT;HENRI JEAN VELGE;BRUNOHUMBLET;LARMUSEAU LIEVEN;VROMANT FRANK Datos registrales. T 644, L 435, F 23, S 8, H BU 6065, I/A 31 (25.07.13).
22 de Agosto de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.790.140,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.107.140,00 Euros. Datos registrales. T 644, L 435, F22, S 8, H BU 6065, I/A 30 (10.08.12).
18 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: ROYO RODES JUAN LUIS. Nombramientos. Secretario: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datosregistrales. T 644, L 435, F 21, S 8, H BU 6065, I/A 28 ( 8.05.12).
Revocaciones. Apoderado: ROYO RODES JUAN LUIS. Apo.Manc.: ROYO RODES JUAN LUIS;ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO.Apoderado: ROYO RODES JUAN LUIS. Apo.Manc.: ROYO RODES JUAN LUIS;ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO. Apo.Man.Soli:LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Apo.Sol.: ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO;MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL;CHAVES MIRANDAROGERIO;MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL;LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Apo.Sol.: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datosregistrales. T 644, L 435, F 21, S 8, H BU 6065, I/A 29 ( 8.05.12).
19 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ROELENS GEERT. Nombramientos. Consejero: VROMANT FRANK. Datos registrales. T 644, L435, F 21, S 8, H BU 6065, I/A 27 (10.01.12).
27 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 443, L 234, F 205, S 8, H BU 6065, I/A25 (14.04.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datos registrales. T 443, L 234, F 205, S 8, H BU 6065, I/A 26(14.04.11).
02 de Septiembre de 2010Reelecciones. Presidente: ALBRECHT DE GRAEVE. Consejero: ALBRECHT DE GRAEVE;HENRI JEAN VELGE;BRUNOHUMBLET;ROELENS GEERT;LARMUSEAU LIEVEN Datos registrales. T 443, L 234, F 205, S 8, H BU 6065, I/A 24 (24.08.10).
16 de Abril de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: URRETA MARTINEZ PEDRO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Datosregistrales. T 443, L 234, F 204, S 8, H BU 6065, I/A 22 ( 3.04.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO. Datos registrales. T 443, L 234, F 204, S 8, H BU 6065, I/A 23 (3.04.09).