Actos BORME de Bekaert Ideal Sl
18 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GHYSELS STEPHAN LOUIS L. Nombramientos. Consejero: DESNE FRANCOIS DENIS NOEL.Datos registrales. T 803, L 594, F 129, S 8, H BU 13049, I/A 32 (11.05.23).
26 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Secretario: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Nombramientos.Consejero: DIEZ PASCUAL GORKA. Secretario: DIEZ PASCUAL GORKA. Datos registrales. T 758, L 549, F 133, S 8, H BU 13049,I/A 29 (20.01.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ PASCUAL GORKA. Datosregistrales. T 803, L 594, F 128, S 8, H BU 13049, I/A 30 (20.01.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES ESPOLIO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 803, L 594, F 129, S 8, H BU 13049, I/A 31(20.01.23).
02 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ALEX VAN RIET PIET PHILEMON. Presidente: ALEX VAN RIET PIET PHILEMON. Nombramientos.Consejero: VOET GEERT AIME M. Presidente: VOET GEERT AIME M. Datos registrales. T 758, L 549, F 133, S 8, H BU 13049, I/A28 (27.05.22).
14 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LUC M. PEETERS FREDERIC. Nombramientos. Consejero: GHYSELS STEPHAN LOUIS L.Reelecciones. Presidente: ALEX VAN RIET PIET PHILEMON. Consejero: ALEX VAN RIET PIET PHILEMON;PAREWYCK STEVENANGELE P. Secretario: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Consejero: CAMILO KOHN DAVID. Datos registrales. T 758, L 549, F132, S 8, H BU 13049, I/A 27 ( 3.12.21).
05 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: VROMANT FRANK. Nombramientos. Consejero: LUC M. PEETERS FREDERIC. Datosregistrales. T 758, L 549, F 132, S 8, H BU 13049, I/A 26 (29.08.19).
27 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ROYO RODES JUAN LUIS. Apo.Manc.: ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO;ROYO RODES JUANLUIS;MESSIAEN CHRISTIAN;DEBLAERE KRISTIN. Apo.Sol.: CALISKAN MEMET METIN. Apo.Manc.: CALISKAN MEMET METIN.Apo.Sol.: CALISKAN MEMET METIN. Nombramientos. Apo.Manc.: CASTILLA ESTEBANEZ SARA. Datos registrales. T 700, L491, F 11, S 8, H BU 13049, I/A 25 (21.05.19).
09 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Consejero: RICHARD COPPE MARC. Nombramientos.Consejero: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Secretario: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Reelecciones. Presidente: ALEX VANRIET PIET PHILEMON. Consejero: CAMILO KOHN DAVID;ALEX VAN RIET PIET PHILEMON. Datos registrales. T 700, L 491, F 10,S 8, H BU 13049, I/A 24 ( 3.10.18).
21 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANANEZ FALCON ALEJANDRO JUAN. Nombramientos. SecreNoConsj: PAREWYCKSTEVEN ANGELE P. Datos registrales. T 700, L 491, F 9, S 8, H BU 13049, I/A 22 (14.03.18).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: SANANEZ FALCON ALEJANDRO JUAN. Revocaciones. Apo.Sol.: SANANEZ FALCONALEJANDRO JUAN. Apo.Manc.: SANANEZ FALCON ALEJANDRO JUAN. Apo.Sol.: SANANEZ FALCON ALEJANDRO JUAN.Nombramientos. Apo.Man.Soli: PAREWYCK STEVEN ANGELE P. Datos registrales. T 700, L 491, F 9, S 8, H BU 13049, I/A 23(14.03.18).
13 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: HUMBLET BRUNO. Nombramientos. Consejero: VROMANT FRANK. Datos registrales. T 700, L491, F 8, S 8, H BU 13049, I/A 21 ( 5.10.16).
13 de Noviembre de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: KOHN TOPFER JUAN DANIEL;VELGE HENRI-JEAN;VOET GEERT.Presidente: VELGE HENRI-JEAN. Nombramientos. Consejero: CAMILO KOHN DAVID;ALEX VAN RIET PIETPHILEMON;RICHARD COPPE MARC. Reelecciones. Consejero: HUMBLET BRUNO. Datos registrales. T 671, L 462, F 120, S 8,H BU 13049, I/A 18 ( 6.11.15).
Nombramientos. Presidente: ALEX VAN RIET PIET PHILEMON. Datos registrales. T 700, L 491, F 7, S 8, H BU 13049, I/A 19 (6.11.15).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 39.433.853,00 Euros. Resultante Suscrito: 48.582.817,00 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 8.097.137,00 Euros. Resultante Suscrito: 40.485.680,00 Euros. Datos registrales. T 700, L 491, F 7, S 8, H BU13049, I/A 20 ( 6.11.15).
11 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: CALISKAN MEMET METIN. Apo.Manc.: CALISKAN MEMET METIN. Apo.Sol.: CALISKAN MEMETMETIN. Datos registrales. T 631, L 422, F 124, S 8, H BU 13049, I/A 15 ( 3.12.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: LAZARO ESTARTA GUSTAVO. Datos registrales. T 631, L 422, F 125, S 8, H BU 13049, I/A 16 (3.12.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Apo.Manc.: CHAVES MIRANDA ROGERIO;CHAVES MIRANDAROGERIO. Apo.Sol.: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datos registrales. T 671, L 462, F 120, S 8, H BU 13049, I/A 17 ( 3.12.13).
04 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: ROYO RODES JUAN LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: SANANEZ FALCON ALEJANDROJUAN. Datos registrales. T 631, L 422, F 124, S 8, H BU 13049, I/A 14 (25.06.12).
18 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: DERVULF RONNY;MESSIAEN CHRISTIAN;GHEKIERE DIRK;DEBLAERE KRISTINE;ROYO RODESJUAN LUIS;ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO;CHAVES MIRANDA ROGERIO. Apoderado: ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO.Nombramientos. Dir. General: SANANEZ FALCON ALEJANDRO JUAN. Apo.Sol.: SANANEZ FALCON ALEJANDRO JUAN;CHAVESMIRANDA ROGERIO. Apo.Manc.: CHAVES MIRANDA ROGERIO;LAZARO ESTARTA GUSTAVO;MONASTERIO LOPEZ MARIAISABEL;GHEKIERE DIRK;MESSIAEN CHRISTIAN;DEBLAERE KRISTIN;CHAVES MIRANDA ROGERIO;LAZARO ESTARTAGUSTAVO;MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL. Apo.Sol.: CHAVES MIRANDA ROGERIO;MONASTERIO LOPEZ MARIA ISABEL.Datos registrales. T 631, L 422, F 122, S 8, H BU 13049, I/A 13 ( 8.05.12).
09 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: OTTO KOHN TOPFER TOMAS. Nombramientos. Consejero: KOHN TOPFER JUAN DANIEL.Reelecciones. Consejero: VELGE HENRI-JEAN;HUMBLET BRUNO;VOET GEERT. Presidente: VELGE HENRI-JEAN. Datosregistrales. T 631, L 422, F 122, S 8, H BU 13049, I/A 12 (27.03.12).
27 de Abril de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: CHAVES MIRANDA ROGERIO. Datos registrales. T 602, L 393, F 119, S 8, H BU 13049, I/A 9(14.04.11).
Nombramientos. Apoderado: ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO. Datos registrales. T 631, L 422, F 122, S 8, H BU 13049, I/A 10(14.04.11).
Revocaciones. Apo.Manc.: URRETA MARTINEZ PEDRO;MORAL TAJADURA MONTSERRAT. Datos registrales. T 631, L 422, F122, S 8, H BU 13049, I/A 11 (14.04.11).
25 de Noviembre de 2010Fe de erratas: Se rectifica la puplicaci贸n del plazo de duraci贸n de los Administradores nombrados en inscripci贸n 3&, siendo la mismapor plazo de TRES A脩OS. Datos registrales. T 602, L 393, F 119, S 8, H BU 13049, I/A 8 (16.11.10).
16 de Octubre de 2009Modificaciones estatutarias. 11. - El cargo de Consejero ser谩 remunerado. El Consejo deAdministraci贸n estar谩 compuesto por unm铆nimo de 4 miembrosy un m谩ximo de 12 miembros, designados por la Junta Generalde socios. . Datos registrales. T 602, L 393, F119, S 8, H BU 13049, I/A 7 ( 6.10.09).
29 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.403.717,00 Euros. Resultante Suscrito: 88.007.051,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:9.619,00 Euros. Resultante Suscrito: 88.016.670,00 Euros. Datos registrales. T 602, L 393, F 116, S 8, H BU 13049, I/A 6 (20.04.09).
27 de Abril de 2009P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 602, L 393, F 115, S 8, H BU 13049, I/A 4 (16.04.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANANEZ FALCON ALEJANDRO JUAN;ROYO RODES JUAN LUIS. Apo.Manc.: SANANEZ FALCONALEJANDRO JUAN;ROYO RODES JUAN LUIS;URRETA MARTINEZ PEDRO;ROMANO DOMINGUEZ ROBERTO;DERVULFRONNY;MESSIAEN CHRISTIAN;GHEKIERE DIRK;DEBLAERE KRISTINE;ROYO RODES JUAN LUIS;ROMANO DOMINGUEZROBERTO;MORAL TAJADURA MONTSERRAT. Datos registrales. T 602, L 393, F 115, S 8, H BU 13049, I/A 5 (16.04.09).