Buscador CIF Logo

Actos BORME Bellersil Property Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bellersil Property Sl

Actos BORME Bellersil Property Sl - B88055900

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Bellersil Property Sl con CIF B88055900

🔙 Perfil de Bellersil Property Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Bellersil Property Sl

28 de Septiembre de 2023
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. laadquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. Datos registrales. T 45190 , F 76, S 8, H M 668686,I/A 14 (21.09.23).

19 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: WENGROFSKY MICHAEL P.;RAQAI CHAOUI NARJISS;NIETO JAUREGUI FRANCISCO JAVIER.Presidente: NIETO JAUREGUI FRANCISCO JAVIER. SecreNoConsj: RUMBAO REAL JOSE LUIS. Revocaciones. Apoderado: DENAVAS CABRE OSCAR;GARCIA COLLADO OSCAR;RUMBAO REAL JOSE LUIS;GUTIERREZ ALONSO JORGE;NIETO JAUREGUIFRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: MONTORO ALEMAN FRANCISCO LUIS. Presidente: MONTORO ALEMANFRANCISCO LUIS. Consejero: MONTORO ALEMAN RICARDO. Vicepresid.: MONTORO ALEMAN RICARDO. Consejero: ABASCALSEBASTIEN PIERRE. SecreNoConsj: GIL PEREZ CARRO ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 11º.Cambio de domicilio social. C/ LUCHANA 23 7ª (MADRID). Datos registrales. T 37511 , F 121, S 8, H M 668686, I/A 11 (12.06.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTORO ALEMAN ANTONIO;MONTORO ALEMAN RICARDO;BARRONDO AGUDINXABIER;GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS;VALIENTE CALVO DIEGO;LLANES GOMEZ SILVIA;SABAH MAZZETAVIVIANNE;CALVO SANCHEZ JORGE;GIL PEREZ CARRO ANTONIO. Datos registrales. T 37511 , F 122, S 8, H M 668686, I/A 12(12.06.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: GMP PROPERTY SOCIMI SA. Datos registrales. T 45190 , F 71, S 8, H M 668686, I/A 13 (12.06.23).

28 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: BEGUIRISTAIN LAHUERTA BLANCA. Datos registrales. T 37511 , F 121, S 8, H M 668686, I/A 10(21.11.22).

23 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apoderado: NIETO JAUREGUI FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 37511 , F 119, S 8, H M 668686, I/A 9(16.05.22).

21 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA COLLADO OSCAR. Consejero: DE NAVAS CABRE OSCAR. Presidente: DE NAVASCABRE OSCAR. Nombramientos. SecreNoConsj: RUMBAO REAL JOSE LUIS. Consejero: NIETO JAUREGUI FRANCISCOJAVIER. Presidente: NIETO JAUREGUI FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 37511 , F 119, S 8, H M 668686, I/A 8 (12.04.22).

18 de Noviembre de 2021
Cambio de domicilio social. C/ GOYA 6, 2 (MADRID). Datos registrales. T 37511 , F 118, S 8, H M 668686, I/A 7 (11.11.21).

06 de Mayo de 2021
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 12 Y APROBACION DE OPERACION DE FINANCIACION, YTRANSACCIONES. Datos registrales. T 37511 , F 117, S 8, H M 668686, I/A 6 (28.04.21).

21 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CROOKS CASEY MICHAEL. Nombramientos. Consejero: RAQAI CHAOUI NARJISS. Datosregistrales. T 37511 , F 117, S 8, H M 668686, I/A 5 (14.09.20).

04 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: GARCIA COLLADO OSCAR;RUMBAO REAL JOSE LUIS;BEGUIRISTAIN LAHUERTABLANCA;GUTIERREZ ALONSO JORGE. Datos registrales. T 37511 , F 116, S 8, H M 668686, I/A 4 (25.02.19).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información