Actos BORME de Benetesa Sa
20 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: YUSTE ZAZO ESTHER. Apoderado: YUSTE ZAZO ESTHER. Datos registrales. T 34100 , F 46, S 8, H M613436, I/A 9 (13.10.22).
08 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apoderado: LLORENS TORRA JOSE. Datos registrales. T 34100 , F 44, S 8, H M 613436, I/A 8 ( 1.09.20).
17 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: LLORENS TORRA JOSE. Secretario: PEREZ CORDERO IGNACIO. Vicepresid.: LLORENS TORRAJOSE. Cons.Del.Sol: PEREZ CORDERO IGNACIO;LLORENS TORRA JOSE. Presidente: EURO PARK SL. Nombramientos.Consejero: LLORENS TORNE ANA MARIA. Presidente: PEREZ CORDERO IGNACIO. Secretario: LLORENS TORNE ANA MARIA.Cons.Del.Sol: PEREZ CORDERO IGNACIO;LLORENS TORNE ANA MARIA. Reelecciones. Consejero: EURO PARK SL;PEREZCORDERO IGNACIO. Representan: LLORENS TORNE ANA MARIA. Datos registrales. T 34100 , F 42, S 8, H M 613436, I/A 6(10.08.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: LLORENS TORNE MERCEDES;LLORENS TORNE RAMON. Datos registrales. T 34100 , F 43, S 8, HM 613436, I/A 7 (10.08.20).
17 de Diciembre de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EURO PARK SL. Datos registrales. T 34100 , F 39, S 8, H M 613436, I/A 3(10.12.15).
Nombramientos. Apoderado: LLORENS TORNE ANA MARIA;YUSTE ZAZO ESTHER. Datos registrales. T 34100 , F 40, S 8, H M613436, I/A 4 (10.12.15).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.860.000,00 Euros. Desembolsado: 1.860.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.860.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.860.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.780.454,00 Euros. Resultante Suscrito:0,00 Euros. Datos registrales. T 34100 , F 42, S 8, H M 613436, I/A 5 (10.12.15).
30 de Noviembre de 2015Cambio de domicilio social. C/ ALMAGRO, NUMERO 11, 1潞 4 (MADRID). Datos registrales. T 34100 , F 39, S 8, H M 613436, I/A2 (20.11.15).
09 de Septiembre de 2015Revocaciones. ADM.CONJUNTO: BAIXAS JIMENO MELCHOR;FERNANDEZ MAS ALEJANDRO. Nombramientos. CONSEJERO:EURO PARK SL. PRESIDENTE: EURO PARK SL. REPR.143 RRM: LLORENS TORNE ANA. CONSEJERO: LLORENS TORRAJOSE. VICEPRESIDEN: LLORENS TORRA JOSE. CONS. DELEG.: LLORENS TORRA JOSE. CONSEJERO: PEREZ CORDEROIGNACIO. SECRETARIO: PEREZ CORDERO IGNACIO. CONS. DELEG.: PEREZ CORDERO IGNACIO. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13,22,25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMENADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 42411 , F 42, S 8, H B 84959, I/A 23 (27.08.15).
05 de Mayo de 2015Nombramientos. ADM.CONJUNTO: BAIXAS JIMENO MELCHOR;FERNANDEZ MAS ALEJANDRO. Datos registrales. T 42411 , F42, S 8, H B 84959, I/A 22 (24.04.15).
14 de Octubre de 2011Modificaciones estatutarias. ART.29 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL,INICIANDOSE EL DIA 1 DENOVIEMBRE Y FINALIZANDO EL 31 DE OCTUBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 42411 , F 42, S 8, H B 84959, I/A 21 (4.10.11).
08 de Agosto de 2011Nombramientos. APODERADO: LLORENS TORNE ANA MARIA;YUSTE ZAZO ESTHER;GONZALEZ CATALAN ANA. Datosregistrales. T 42411 , F 41, S 8, H B 84959, I/A 20 (27.07.11).
15 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 676.094,45 Euros. Desembolsado: 676.094,45 Euros. Resultante Suscrito: 1.780.454,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.780.454,00 Euros. Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.327 P.2 PTA.2 (BARCELONA).Cambio de objeto social. a) LA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE INDUSTRIAS DE
09 de Agosto de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 924.055,95 Euros. Desembolsado: 924.055,95 Euros. Resultante Suscrito: 1.104.359,55 Euros.Resultante Desembolsado: 1.104.359,55 Euros. Datos registrales. T 25166 , F 85, S 8, H B 84959, I/A 18 (28.07.10).
02 de Agosto de 2010Revocaciones. ADM.CONJUNTO: ESTARLI COLL JOSE MARIA;MARTINEZ TRIPIANA JORGE. Nombramientos.ADM.CONJUNTO: BAIXAS JIMENO MELCHOR;FERNANDEZ MAS ALEJANDRO. Modificaciones estatutarias. ART.25.-REPRESENTACION SOCIEDAD. Datos registrales. T 25166 , F 84, S 8, H B 84959, I/A 17 (21.07.10).