Actos BORME de Beniconfort Sociedad Anonima
11 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLES ROMAN MANUEL;CASTRO MARIN JUAN RAFAEL;SANS BATISTE JOSE;DONOSOGALINDO SANTIAGO;FEBRER MARQUES JUAN ANTONIO. Presidente: FEBRER MARQUES JUAN ANTONIO. Con.Delegado:FEBRER MARQUES JUAN ANTONIO. Vicepresid.: DONOSO GALINDO SANTIAGO. Secretario: SANS BATISTE JOSE. Consejero:URQUIZU MEJIAS JUAN MANUEL;BOTI GUIMERA DOMINGO. Nombramientos. Liquidador: FEBRER MARQUES JUANANTONIO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 743, L 310, F 222, S 8, H CS 8546, I/A 17 (30.01.20).
22 de Agosto de 2018Reducción de capital. Importe reducción: 13.702,80 Euros. Resultante Suscrito: 58.417,20 Euros. Ampliación de capital. Suscrito:14.482,80 Euros. Desembolsado: 14.482,80 Euros. Resultante Suscrito: 72.900,00 Euros. Resultante Desembolsado: 72.900,00 Euros.Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: reduccion y ampliacion capital. mod. art.. Datos registrales. T 743, L 310, F222, S 8, H CS 8546, I/A 16 (14.08.18).
10 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GERONA MAURA JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: URQUIZU MEJIAS JUANMANUEL;BOTI GUIMERA DOMINGO. Reelecciones. Consejero: ROBLES ROMAN MANUEL;FEBRER MARQUES JUANANTONIO;DONOSO GALINDO SANTIAGO;SANS BATISTE JOSE;CASTRO MARIN JUAN RAFAEL. Presidente: FEBRER MARQUESJUAN ANTONIO. Vicepresid.: DONOSO GALINDO SANTIAGO. Secretario: SANS BATISTE JOSE. Con.Delegado: FEBRERMARQUES JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 743, L 310, F 222, S 8, H CS 8546, I/A 15 (31.07.18).
29 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARZA RUZAFA VICENTE JOAQUIN. Modificaciones estatutarias. mod. primer párrafo articulo11. Datos registrales. T 743, L 310, F 222, S 8, H CS 8546, I/A 14 (21.07.15).
20 de Febrero de 2014Modificaciones estatutarias. Modificado el Artículo 17º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 743, L 310, F 221, S 8, H CS8546, I/A 13 (11.02.14).
03 de Abril de 2012Nombramientos. Auditor: INGARAS SLP. Datos registrales. T 743, L 310, F 221, S 8, H CS 8546, I/A 12 (26.03.12).
15 de Marzo de 2012Reelecciones. Consejero: CASTRO MARIN JUAN RAFAEL;FEBRER MARQUES JUAN ANTONIO;DONOSO GALINDOSANTIAGO;SANS BATISTE JOSE;GERONA MAURA JOSE ENRIQUE;ROBLES ROMAN MANUEL;MARZA RUZAFA VICENTEJOAQUIN. Presidente: FEBRER MARQUES JUAN ANTONIO. Vicepresid.: DONOSO GALINDO SANTIAGO. Secretario: SANSBATISTE JOSE. Con.Delegado: FEBRER MARQUES JUAN ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos:Modificado el segundo párrafo del Artículo 17º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 743, L 310, F 221, S 8, H CS 8546, I/A11 ( 5.03.12).
10 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: BOTI MIRALLES DOMINGO. Datos registrales. T 743, L 310, F 221, S 8, H CS 8546, I/A 10(26.04.11).