Actos BORME de Bensa Sa
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: YUSTE ZAZO ESTHER. Apo.Sol.: YUSTE ZAZO ESTHER. Datos registrales. T 247 , F 128, S 8, H L4329, I/A 31 (27.10.22).
25 de Febrero de 2022Modificaciones estatutarias. Creaci贸n de los art铆culos 19 bis y 24 bis.. Datos registrales. T 241 , F 55, S 8, H L 4329, I/A 29(17.02.22).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: LLORENS TORNE MERCEDES. Presidente: LLORENS TORNE MERCEDES. Consejero:LLORENS TORNE MERCEDES. Vicepresid.: LLORENS TORRA JOSE. Nombramientos. Consejero: LLORENS TORNE ANAMARIA. Cons.Del.Sol: LLORENS TORNE ANA MARIA. Presidente: LLORENS TORRA JOSE. Vicepresid.: LLORENS TORNE ANAMARIA. Reelecciones. Secretario: PEREZ CORDERO IGNACIO. Consejero: PEREZ CORDERO IGNACIO;LLORENS TORRAJOSE. Cons.Del.Sol: LLORENS TORRA JOSE;PEREZ CORDERO IGNACIO. Datos registrales. T 241 , F 55, S 8, H L 4329, I/A 30(17.02.22).
04 de Diciembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 300.600,00 Euros. Desembolsado: 300.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.503.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.503.000,00 Euros. Datos registrales. T 241 , F 55, S 8, H L 4329, I/A 28 (27.11.17).
21 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: LLORENS TORNE MERCEDES;LLORENS TORRA JOSE;PEREZ CORDERO IGNACIO.Nombramientos. Cons.Del.Sol: PEREZ CORDERO IGNACIO;LLORENS TORRA JOSE;LLORENS TORNE MERCEDES.Reelecciones. Consejero: PEREZ CORDERO IGNACIO;LLORENS TORNE MERCEDES;LLORENS TORRA JOSE. Datosregistrales. T 241 , F 54, S 8, H L 4329, I/A 27 ( 9.03.17).
15 de Marzo de 2017Nombramientos. Vicepresid.: LLORENS TORRA JOSE. Fe de erratas: En el Bolet铆n 62/12 y con la ref 145939 se han publicado losactos de la i/a 22 de BENSA SA, habi茅ndose omitido, por error, el de nombramiento de JOSE LLORENS TORRA como Vicepresidentedel Consejo de Administraci贸n, lo cual se indica para su subsanaci贸n. Datos registrales. T 239 , F 152, S 8, H L 4329, I/A 22(20.03.12).
09 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.142.280,00 Euros. Desembolsado: 1.142.280,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.202.400,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.202.400,00 Euros. Datos registrales. T 241 , F 35, S 8, H L 4329, I/A 26 (30.11.15).
24 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: AGUILA BATALLA ALEJANDRA. Datos registrales. T 239 , F 153, S 8, H L 4329, I/A 24 (17.04.15).
Revocaciones. Apoderado: BATALLA CAMARASA PEDRO. Datos registrales. T 241 , F 35, S 8, H L 4329, I/A 25 (17.04.15).
06 de Marzo de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AGRO RICESA SL. Datos registrales. T 239 , F 152, S 8, H L 4329, I/A 23(26.02.14).
29 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTILLAS GARCIA NICOLAS. Vicepresid.: CORTILLAS GARCIA NICOLAS. Con.Delegado:CORTILLAS GARCIA NICOLAS;PEREZ CORDERO IGNACIO;LLORENS TORNE MERCEDES. Nombramientos. Consejero:LLORENS TORRA JOSE. Con.Delegado: LLORENS TORNE MERCEDES;LLORENS TORRA JOSE;PEREZ CORDERO IGNACIO.Reelecciones. Consejero: PEREZ CORDERO IGNACIO;LLORENS TORNE MERCEDES. Datos registrales. T 239 , F 152, S 8, H L4329, I/A 22 (20.03.12).
06 de Octubre de 2011Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/10. Datos registrales. T 239 , F 151, S 8, H L 4329, I/A 21 (27.09.11).
06 de Abril de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: LLORENS TORNE ANA MARIA;GONZALEZ CATALAN ANA;YUSTE ZAZO ESTHER. Datos registrales.T 239 , F 151, S 8, H L 4329, I/A 20 (28.03.11).