Actos BORME de Beposana Servicios Y Gestiones Sl
30 de Mayo de 2022Cambio de objeto social. La actividadprincipal de la Sociedad es lagesti贸ny administraci贸n de valores representativos de losfondospropios de entidades residentes y no residentes en territorio espa帽ol, mediante la correspondiente organizaci贸n de medios materiales ypersonales... Datos registrales. T 29211 , F 142, S 8, H M 525878, I/A 13 (23.05.22).
10 de Diciembre de 2021Cambio de domicilio social. PASEO DE RECOLETOS 37-41 - 3陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 29211 , F 142, S 8, H M525878, I/A 12 ( 1.12.21).
30 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;SAEZ SERRANO SARA;VAZQUEZ PAVELECK MARIADOLORES;SUAREZ SEIJAS SOFIA;ARANDA HERRERO JAVIER;ALBACETE PORTILLO ELENA. Datos registrales. T 29211 , F141, S 8, H M 525878, I/A 11 (23.09.21).
27 de Enero de 2020Nombramientos. Consejero: SAEZ SERRANO SARA. Datos registrales. T 29211 , F 141, S 8, H M 525878, I/A 10 (20.01.20).
22 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Apo.Sol.: MOCHALES FORERO PAULA. Nombramientos.Apoderado: SAEZ SERRANO SARA. Datos registrales. T 29211 , F 140, S 8, H M 525878, I/A 9 (15.01.20).
19 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DIEZ ISABEL. Vicesecret.: GOMEZ DIEZ ISABEL. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZDIEZ ISABEL. Datos registrales. T 29211 , F 140, S 8, H M 525878, I/A 8 (12.12.19).
03 de Diciembre de 2019Cambio de domicilio social. C/ O'DONNELL 12 - 6陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 29211 , F 140, S 8, H M 525878, I/A7 (26.11.19).
04 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: STEINVORTH HERRERA WILHELM;STEINVORTH HERRERA MARLISE;GONZALEZ HERNANDEZPALOMA;GOMEZ DIEZ ISABEL. Datos registrales. T 29211 , F 139, S 8, H M 525878, I/A 6 (21.02.13).
03 de Diciembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.003.010,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 19.Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 29211 , F 138, S 8, H M 525878, I/A 5 (21.11.12).
29 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Nombramientos. Consejero:STEINVORTH HERRERA WILHELM JOSE;STEINVORTH HERRERA MARLISE;GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZPALOMA. Presidente: STEINVORTH HERRERA WILHELM JOSE. Secretario: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Vicesecret.:GOMEZ DIEZ ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 29211 , F 136, S 8, H M 525878, I/A 3 (20.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;GOMEZ DIEZISABEL;STEINVORTH HERRERA WILHELM JOSE. Apo.Sol.: MOCHALES FORERO PAULA. Datos registrales. T 29211 , F 137, S8, H M 525878, I/A 4 (20.11.12).
24 de Enero de 2012Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: WAYBY HOLDING NV. Ceses/Dimisiones. Representan: CABANAS NAVAZOBLANCA PILAR. Adm. Unico: IC NON RESIDENTS SL. Nombramientos. Adm. Solid.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZHERNANDEZ PALOMA GLORIA. Apoderado: CITCO CORPORATE MANAGEMENT -MADRID- SL. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Cambio de domicilio social. C/ PINAR 7 5IZ (MADRID). Datos registrales. T 29211 , F 136, S 8, H M 525878, I/A 2 (12.01.12).
31 de Octubre de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.10.11. Objeto social: LA ASESORIA, Y CONSULTORIA DE EMPRESAS DE TODO TIPOGERENCIAL, INFORMATICO, DE INVERSION Y DE INTERMEDIACION, COMUNICACION COMERCIAL, FISCAL, CONTABLE YPARA PRESTACION DE SERVICIOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INDOLE INFORMATICO. Domicilio:AVDA FELIPE II 17 1潞 1 (MADRID). Capital: 3.010,00 Euros. Nombramientos. Representan: CABANAS NAVAZO BLANCA PILAR.Adm. Unico: IC NON RESIDENTS SL. Datos registrales. T 29211 , F 134, S 8, H M 525878, I/A 1 (20.10.11).