Actos BORME de Berf Spain Madrid Villaverde Sl
29 de Noviembre de 2023Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL N潞56 LOCAL MODULO B PLANTA QUINTA (MADRID). Datos registrales. T36873 , F 199, S 8, H M 640883, I/A 12 (22.11.23).
23 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN BEEK JAN. Secretario: VAN BEEK JAN. Consejero: GUARDIOLA OSBORNEEDUARDO;HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER. Presidente: GUARDIOLA OSBORNE EDUARDO. Vicepresid.: HORTELANO DELA LASTRA JAVIER. Cons.Del.Man: VAN BEEK JAN;GUARDIOLA OSBORNE EDUARDO;HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER.Nombramientos. Adm. Mancom.: PEREZ MARTIN ANA MARIA;GUARDIOLA OSBORNE EDUARDO. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 36873 , F 199, S 8,H M 640883, I/A 11 (16.12.21).
12 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: SAVILLS AGUIRRE NEWMAN CONSULTORES SA. Datos registrales. T 36873 , F 198, S 8, H M640883, I/A 10 ( 4.11.21).
25 de Junio de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CATELLA CER HOLDING SPAIN SL. Datos registrales. T 36873 ,F 198, S 8, H M 640883, I/A 9 (18.06.20).
10 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ALONSO DREGI RAFAEL. Datos registrales. T 36873 , F 197, S 8, H M 640883, I/A 8 (3.03.20).
18 de Diciembre de 2018Cambio de domicilio social. C/ FORTUNY 39 1 (MADRID). Datos registrales. T 36873 , F 197, S 8, H M 640883, I/A 7 (11.12.18).
04 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: LAUERBACH KERSTIN ANKE. Vicepresid.: LAUERBACH KERSTIN ANKE. Consejero:BOESSENKOOL MARNIX GUILLAUME. Presidente: BOESSENKOOL MARNIX GUILLAUME. Revocaciones. Apo.Manc.: VANBEEK JAN;LAUERBACH KERSTIN ANKE;BOESSENKOOL MARNIX GUILLAUME. Nombramientos. Consejero: GUARDIOLAOSBORNE EDUARDO;HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER. Presidente: GUARDIOLA OSBORNE EDUARDO. Vicepresid.:HORTELANO DE LA LASTRA JAVIER. Cons.Del.Man: VAN BEEK JAN;GUARDIOLA OSBORNE EDUARDO;HORTELANO DE LALASTRA JAVIER. Datos registrales. T 36873 , F 197, S 8, H M 640883, I/A 6 (27.06.18).
19 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DUBOIS MICHIEL. Presidente: DUBOIS MICHIEL. Revocaciones. Apoderado: VAN BEEKJAN;LAUERBACH KERSTIN ANKE;DUBOIS MICHIEL. Nombramientos. Consejero: BOESSENKOOL MARNIX GUILLAUME.Presidente: BOESSENKOOL MARNIX GUILLAUME. Apo.Manc.: VAN BEEK JAN;LAUERBACH KERSTIN ANKE;BOESSENKOOLMARNIX GUILLAUME. Datos registrales. T 36873 , F 195, S 8, H M 640883, I/A 5 ( 9.04.18).
22 de Marzo de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.020.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.023.000,00 Euros. Datos registrales. T 35661 , F 203, S8, H M 640883, I/A 4 (15.03.18).
12 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL. Datos registrales. T 35661 , F 203, S 8, H M 640883, I/A 3 (5.02.18).