Actos BORME de Bergareche Sugamon Madrid Sl
18 de Diciembre de 2023Nombramientos. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 30741 , F 126, S 8, H M 27017, I/A 37 (11.12.23).
13 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: BARRAGAN FERNANDEZ VICTOR MANUEL;BARRAGAN FERNANDEZ VICTOR MANUEL;DELGADOBUENO CARMELO;ALVARO NOGALES JOSE IVAN;ANDUJAR JIMENEZ ISABEL. Apo.Sol.: URIBE GAMON RAFAEL. Datosregistrales. T 30741 , F 126, S 8, H M 27017, I/A 36 ( 6.06.23).
14 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 30741 , F 126, S 8, H M 27017, I/A 35 ( 7.02.23).
01 de Junio de 2022Nombramientos. Auditor: ASPROA SL. Datos registrales. T 30741 , F 125, S 8, H M 27017, I/A 34 (25.05.22).
22 de Marzo de 2022Cambio de domicilio social. C/ RIOS ROSAS 11 1 (MADRID). Datos registrales. T 30741 , F 125, S 8, H M 27017, I/A 33(15.03.22).
28 de Mayo de 2021Nombramientos. Auditor: A3 AUDITORES ASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 30741 , F 125, S 8, H M 27017, I/A32 (21.05.21).
10 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: HENCHE GARCIA JOSE MARIA;URIBE GAMON FERNANDO;BERGARECHE IÑURRATEGUI JOSEIGNACIO;GARCIA MAGRO MARIA MERCEDES;BALLESTEROS ESLAVA MAXIMINO. Apo.Sol.: URIBE GAMON LUIS FERNANDO.Datos registrales. T 30741 , F 124, S 8, H M 27017, I/A 31 ( 3.09.19).
17 de Junio de 2019Nombramientos. Auditor: DIECINUEVE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 30741 , F 124, S 8, H M 27017, I/A 30 (10.06.19).
18 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: URIBE GAMON FERNANDO. Consejero: URIBE GAMON FERNANDO. Nombramientos.Presidente: URIBE DE-AGUIRRE PILAR. Vicepresid.: URIBE DE-AGUIRRE FERNANDO. Datos registrales. T 30741 , F 124, S 8, HM 27017, I/A 29 (11.01.19).
14 de Agosto de 2018Reelecciones. Presidente: URIBE GAMON FERNANDO. Consejero: URIBE GAMON FERNANDO;URIBE GAMON RAFAEL. Datosregistrales. T 30741 , F 124, S 8, H M 27017, I/A 28 ( 7.08.18).
25 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: BARRAGAN RASO LUIS;HENCHE GARCIA JOSE MARIA;GARCIA MAGRO MARIAMERCEDES;BARRAGAN RASO LUIS;HENCHE GARCIA JOSE MARIA;GARCIA MAGRO MARIA MERCEDES;BARRAGAN RASOLUIS;BLAZQUEZ ECHAUZ JOSE RAMON;PEREIRA COLLADO ANTONIO;ALONSO ALONSO ENRIQUE. Nombramientos.Apo.Sol.: URIBE GAMON LUIS FERNANDO;URIBE GAMON RAFAEL;URIBE AGUIRRE FERNANDO;URIBE AGUIRRE PILAR.Datos registrales. T 30741 , F 122, S 8, H M 27017, I/A 27 (18.04.18).
28 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRAGAN RASO LUIS. Secretario: BARRAGAN RASO LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj:FERNANDEZ GARCIA IGNACIO JAVIER. Consejero: URIBE DE-AGUIRRE FERNANDO;URIBE DE-AGUIRRE PILAR. Cambio dedomicilio social. C/ SANTA ENGRACIA 151 - PLANTA 5ª, OFICINA 1 (MADRID). Datos registrales. T 30741 , F 122, S 8, H M27017, I/A 26 (21.03.18).
19 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MAGRO MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 30741 , F 121, S 8, H M 27017, I/A 25(10.10.17).
02 de Junio de 2017Nombramientos. Auditor: AUDISERTAC AUDITORES ASESORES FORMADORES SLP. Datos registrales. T 30741 , F 121, S 8, HM 27017, I/A 24 (26.05.17).
06 de Mayo de 2016Nombramientos. Auditor: ABALANCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 30741 , F 121, S 8, H M 27017, I/A 23 (27.04.16).
03 de Junio de 2015Nombramientos. Auditor: GLOBAL AUDITORES Y ADMINISTRADORES SLP. Datos registrales. T 30741 , F 121, S 8, H M 27017,I/A 22 (26.05.15).
26 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: BARRAGAN FERNANDEZ VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 1454 , F 225, S 8, H M 27017, I/A21 (18.02.13).
20 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: BARRAGAN FERNANDEZ VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 1454 , F 225, S 8, H M 27017, I/A20 ( 7.11.12).
16 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BALLESTEROS ESLAVA MAXIMINO. Nombramientos. Consejero: GARCIA MAGRO MARIAMERCEDES. Datos registrales. T 1454 , F 224, S 8, H M 27017, I/A 19 ( 5.10.09).