Actos BORME de Berge Maritima Norte Sociedad Limitada
24 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BILBAO ANA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;MARTIN FRANCO JORGE.Nombramientos. Apoderado: VITAL URGOITI CARLOS;PEREZ LOPEZ ELENA MARIA;CUTANDA ESCRIBANO MARIA. Datosregistrales. T 5391 , F 193, S 8, H BI 51128, I/A 46 ( 8.08.23).
24 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: GAMEZ MARTINEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 5391 , F 193, S 8, H BI 51128, I/A 45(15.02.23).
28 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: ZABALA FERNANDEZ GORKA. Nombramientos. Apoderado: GARCIA NAVARRO PEDRO. Datosregistrales. T 5391 , F 193, S 8, H BI 51128, I/A 44 (16.12.22).
29 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DORIGA ESCALANTE JUAN. Nombramientos. Apoderado: GARCIA NAVARRO PEDRO.Datos registrales. T 5391 , F 192, S 8, H BI 51128, I/A 43 (21.07.22).
22 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: CANEL CRESPO RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: BARRERA PULIDO FRANCISCO DAVID.Datos registrales. T 5391 , F 192, S 8, H BI 51128, I/A 42 ( 3.03.22).
10 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: ROCARIES THIERRY. Nombramientos. Apoderado: GARCIA NAVARRO PEDRO. Datos registrales.T 5391 , F 192, S 8, H BI 51128, I/A 41 (29.11.21).
14 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DESALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZ LARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTAISABEL;FERNANDEZ BILBAO ANA. Datos registrales. T 5391 , F 192, S 8, H BI 51128, I/A 39 ( 5.10.21).
03 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: ORMAZA URTIAGA GORKA JON. Datos registrales. T 5391 , F 191, S 8, H BI 51128, I/A 38 (19.11.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA NAVARRO PEDRO. Datos registrales. T 5391 , F 191, S 8, H BI 51128, I/A 37 (16.06.20).
12 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZLARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL;FERNANDEZ BILBAO ANA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANABELEN;MARTIN FRANCO JORGE. Datos registrales. T 5391 , F 190, S 8, H BI 51128, I/A 36 ( 4.02.20).
24 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: GARCIA BORREGUERO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: CANEL CRESPO RAFAEL. Datosregistrales. T 5391 , F 190, S 8, H BI 51128, I/A 35 (17.01.19).
07 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ROCARIES THIERRY. Datos registrales. T 5391 , F 190, S 8, H BI 51128, I/A 34 (28.11.18).
08 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: ZABALA FERNANDEZ GORKA. Datos registrales. T 5391 , F 189, S 8, H BI 51128, I/A 32 (28.12.17).
11 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DORIGA ESCALANTE JUAN. Datos registrales. T 5391 , F 189, S 8, H BI 51128, I/A 31 (4.10.17).
04 de Octubre de 2017Cambio de domicilio social. C/ SAN VICENTE 8 - EDIFICIO ALBIA I (BILBAO). Datos registrales. T 5391 , F 189, S 8, H BI 51128,I/A 30 (26.09.17).
18 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: ZABALA FERNANDEZ GORKA. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BILBAO ANA. Datosregistrales. T 5391 , F 188, S 8, H BI 51128, I/A 29 ( 5.04.17).
19 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA BORREGUERO JAVIER. Datos registrales. T 5391 , F 188, S 8, H BI 51128, I/A 28 (7.12.16).
15 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU. Nombramientos. Apoderado: DIAZ LARRIETAKOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL. Datos registrales. T 5391 , F 187, S 8, H BI 51128, I/A 27 ( 7.04.16).
23 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA-BORREGUERO MANZANARES JAVIER. Datos registrales. T 5391 , F 187, S 8, H BI51128, I/A 25 (14.10.15).