Buscador CIF Logo

Actos BORME Berge Servicios Siderurgicos Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Berge Servicios Siderurgicos Sl

Actos BORME Berge Servicios Siderurgicos Sl - B83958918

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Berge Servicios Siderurgicos Sl con CIF B83958918

🔙 Perfil de Berge Servicios Siderurgicos Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Berge Servicios Siderurgicos Sl

16 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 20017 , F 217, S 8, H M 353025, I/A 29 ( 8.11.23).

12 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;MARTIN FRANCO JORGE. Nombramientos. Apoderado:CUTANDA ESCRIBANO MARIA. Datos registrales. T 20017 , F 216, S 8, H M 353025, I/A 26 ( 5.06.23).

01 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 20017 , F 216, S 8, H M 353025, I/A 25 (24.11.22).

15 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 20017 , F 214, S 8, H M 353025, I/A 23 ( 8.06.22).

Nombramientos. Apoderado: VILALLONGA GORTAZAR BOSCO. Datos registrales. T 20017 , F 215, S 8, H M 353025, I/A 24 (8.06.22).

13 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ-VELILLA HERNANDEZ FRANCISCA-MARIA. Datos registrales. T 20017 , F 214, S 8, HM 353025, I/A 22 ( 6.05.22).

28 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: SANGORRIN SEBASTIAN DANIEL. Datos registrales. T 20017 , F 213, S 8, H M 353025, I/A 21(21.03.22).

01 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 20017 , F 213, S 8, H M 353025, I/A 20 (24.11.21).

26 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANABELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;ARREDONDO PORTILLA AINHOA;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO. Apoderado: DIAZ LARRIETAKOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL. Datos registrales. T 20017 , F 213, S 8, H M 353025, I/A 19 (19.11.21).

20 de Agosto de 2021
Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 20 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 20017 , F 213, S 8, H M 353025, I/A18 (13.08.21).

18 de Noviembre de 2020
Modificaciones estatutarias. Se crea el artículo 6º bis de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 20017 , F 212, S 8, H M353025, I/A 17 (11.11.20).

09 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 20017 , F 212, S 8, H M 353025, I/A 16 ( 2.10.20).

14 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-VELILLA HERNANDEZ FRANCISCA-MARIA. Datos registrales. T 20017 , F 211, S 8,H M 353025, I/A 15 ( 6.05.20).

10 de Marzo de 2020
Declaración de unipersonalidad. Socio único: BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL. Datosregistrales. T 20017 , F 211, S 8, H M 353025, I/A 14 ( 3.03.20).

03 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;GONZALEZ TOJO ANDRES;DIAZLARRIETA KOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANA BELEN;ARREDONDOPORTILLA AINHOA;MARTIN FRANCO JORGE. Datos registrales. T 20017 , F 211, S 8, H M 353025, I/A 13 (25.02.20).

09 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP (EXTINGUIDA). Datos registrales. T 20017 , F 111, S 8, H M 353025, I/A 12 (2.10.19).

05 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 20017 , F 111, S 8, H M 353025, I/A 11 (28.12.16).

03 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU. Nombramientos. Apoderado: DIAZ LARRIETAKOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL. Datos registrales. T 20017 , F 111, S 8, H M 353025, I/A 10 (26.10.15).

04 de Septiembre de 2013
Cambio de domicilio social. C/ ALCALA NUMERO 65 (MADRID). Datos registrales. T 20017 , F 110, S 8, H M 353025, I/A 9(23.08.13).

27 de Julio de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMMA MATILDE. Datos registrales. T 20017 , F 110, S 8, H M 353025, I/A 8(18.07.12).

04 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;IGLESIASSANZ ALBERTO;MUÑOZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTIN CORPA

07 de Julio de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZ DE SALAZAR DE VIANABELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;DOPICO RUIZ MARIA ARANZAZU;ARREDONDO PORTILLA AINHOA;AGUIRRE OLORIZIGNACIO. Datos registrales. T 20017 , F 109, S 8, H M 353025, I/A 6 (24.06.11).

07 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZALICIA;IGLESIAS SANZ ALBERTO;MUÑOZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTINCORPA CRISTINA;ORDOÑEZ PEREZ MARIA-JOSE;CEPEDA BAZA VANESSA;PEREZ DEL NOTARIO PUENTE ELENA;CERONECHEVARRIA SOLEDAD. Datos registrales. T 20017 , F 108, S 8, H M 353025, I/A 5 (24.11.10).

31 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLANO USCOLA TOMAS. Nombramientos. Representan: OLANO USCOLA TOMAS. Adm. Unico:BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL. Datos registrales. T 20017 , F 108, S 8, H M 353025, I/A 4(18.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información