Buscador CIF Logo

Actos BORME Bernesga Motor Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bernesga Motor Sl

Actos BORME Bernesga Motor Sl - B86890779

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Bernesga Motor Sl con CIF B86890779

馃敊 Perfil de Bernesga Motor Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Bernesga Motor Sl

27 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SOLIS PAULA. Datos registrales. T 31792 , F 46, S 8, H M 572086, I/A 13 (19.12.23).

23 de Enero de 2023
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 31792 , F 46, S 8, H M 572086, I/A 12 (16.01.23).

09 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 31792 , F 46, S 8, H M 572086, I/A 11 (30.11.22).

12 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BANIELLO IRMA;MENENDEZ VELASCO CONCEPCION;TADEO GARCIA SARA. Datosregistrales. T 31792 , F 45, S 8, H M 572086, I/A 10 ( 5.09.22).

13 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSOPURIFICACION. Reelecciones. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T31792 , F 45, S 8, H M 572086, I/A 9 ( 6.02.20).

21 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 31792 , F 45, S 8, H M 572086, I/A 8 (14.01.20).

21 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: CUETO VELASCO CARLOTA;LOPEZ MELON ANGEL. Datos registrales. T 31792 , F 44, S 8, H M572086, I/A 7 (10.03.17).

20 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 31792 , F 44, S 8, H M 572086, I/A 6 (12.01.17).

03 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION;MARTINEZ ALONSOROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Presidente: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Secretario: ALONSO GARCIA MARIAPURIFICACION. Cons.Del.Sol: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION. Nombramientos. Adm.Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 31792 , F 43, S 8, H M572086, I/A 5 (27.01.16).

06 de Junio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 31792 , F 43, S 8, H M 572086, I/A 4 (29.05.14).

21 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 31792 , F 43, S 8, H M 572086, I/A 3 (14.01.14).

16 de Enero de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 31792 , F 42, S8, H M 572086, I/A 2 ( 8.01.14).

15 de Enero de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.12.13. Objeto social: COMPRVENTA, REPARACION, MANTEMIENTO, FABRICACION,ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, ASI COMO SUS PIEZAS, COMPONENETES,ACCESORIOS Y REPUESTOS. Domicilio: C/ GENERAL ARRANDO, NUMERO 9 -BIS, BAJO (MADRID). Capital: 600.000,00 Euros.Nombramientos. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION;MARTINEZ ALONSOROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Presidente: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Secretario: ALONSO GARCIA MARIAPURIFICACION. Cons.Del.Sol: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T31792 , F 40, S 8, H M 572086, I/A 1 ( 7.01.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n