Actos BORME de Bernesga Motor Sl
27 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SOLIS PAULA. Datos registrales. T 31792 , F 46, S 8, H M 572086, I/A 13 (19.12.23).
23 de Enero de 2023Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 31792 , F 46, S 8, H M 572086, I/A 12 (16.01.23).
09 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 31792 , F 46, S 8, H M 572086, I/A 11 (30.11.22).
12 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BANIELLO IRMA;MENENDEZ VELASCO CONCEPCION;TADEO GARCIA SARA. Datosregistrales. T 31792 , F 45, S 8, H M 572086, I/A 10 ( 5.09.22).
13 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSOPURIFICACION. Reelecciones. Adm. Solid.: MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T31792 , F 45, S 8, H M 572086, I/A 9 ( 6.02.20).
21 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 31792 , F 45, S 8, H M 572086, I/A 8 (14.01.20).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: CUETO VELASCO CARLOTA;LOPEZ MELON ANGEL. Datos registrales. T 31792 , F 44, S 8, H M572086, I/A 7 (10.03.17).
20 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 31792 , F 44, S 8, H M 572086, I/A 6 (12.01.17).
03 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION;MARTINEZ ALONSOROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Presidente: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Secretario: ALONSO GARCIA MARIAPURIFICACION. Cons.Del.Sol: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION. Nombramientos. Adm.Solid.: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 31792 , F 43, S 8, H M572086, I/A 5 (27.01.16).
06 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 31792 , F 43, S 8, H M 572086, I/A 4 (29.05.14).
21 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RUIZ JULIA. Datos registrales. T 31792 , F 43, S 8, H M 572086, I/A 3 (14.01.14).
16 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ ALONSO ROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 31792 , F 42, S8, H M 572086, I/A 2 ( 8.01.14).
15 de Enero de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.12.13. Objeto social: COMPRVENTA, REPARACION, MANTEMIENTO, FABRICACION,ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, ASI COMO SUS PIEZAS, COMPONENETES,ACCESORIOS Y REPUESTOS. Domicilio: C/ GENERAL ARRANDO, NUMERO 9 -BIS, BAJO (MADRID). Capital: 600.000,00 Euros.Nombramientos. Consejero: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION;MARTINEZ ALONSOROSA;MARTINEZ ALONSO ALBERTO. Presidente: MARTINEZ CUERVO ALFREDO. Secretario: ALONSO GARCIA MARIAPURIFICACION. Cons.Del.Sol: MARTINEZ CUERVO ALFREDO;ALONSO GARCIA MARIA PURIFICACION. Datos registrales. T31792 , F 40, S 8, H M 572086, I/A 1 ( 7.01.14).