Actos BORME de Berrilore Xxi Sl
09 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MENOR PEREZ JAVIER ALBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: CONSULTORES SAYMASOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 2865 , F 37, S 8, H SS 40917, I/A 10 (25.08.22).
17 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCH DE FRANCISCO JORDI;SAIZ GONZALEZ JESUS. Presidente: FRANCH DE FRANCISCOJORDI. Nombramientos. Consejero: COX GRANT LESLIE;BENDER STEPHEN DAVID. Presidente: BENDER STEPHEN DAVID.Datos registrales. T 2865 , F 35, S 8, H SS 40917, I/A 7 ( 3.09.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: RIOS MARTIN CRISTINA;MU脩OZ NAVARRO ALEJANDRA. Datos registrales. T 2865 , F 35, S 8, H SS40917, I/A 8 ( 3.09.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: SAIZ GONZALEZ JESUS;FRANCH DE FRANCISCO JORDI. Apo.Man.Soli: DEL POZO POVEDA OSCARLUIS;SAIZ GONZALEZ JESUS;FRANCH DE FRANCISCO JORDI. Nombramientos. Apo.Man.Soli: COX GRANT LESLIE;DEL POZOPOVEDA OSCAR LUIS. Datos registrales. T 2865 , F 35, S 8, H SS 40917, I/A 9 ( 3.09.20).
11 de Noviembre de 2019Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 2865 , F 34, S 8, H SS 40917, I/A 6(29.10.19).
08 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL POZO POVEDA OSCAR LUIS;FRANCH DE FRANCISCO JORDI;SAIZ GONZALEZ JESUS.Datos registrales. T 2865 , F 33, S 8, H SS 40917, I/A 5 (26.10.18).
26 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: FRANCH DE FRANCISCO JORDI;SAIZ GONZALEZ JESUS. Datos registrales. T 2865 , F 33, S 8, H SS40917, I/A 3 (15.10.18).
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Cambio de domicilio social. POLIG LANBARREN, C/ARA脩ABURU, N潞 6.- (OIARTZUN). Cambio de objeto social. - El comercio, tanto al mayor como al menor, la importaci贸n y laexportaci贸n de toda clase de productos de alimentaci贸n. - La prestaci贸n de servicios administrativos, financieros, log铆sticos, elasesoramiento comercial y de estrategia, desarrollo de producto o negocio y la gesti贸n de las sociedades. Datos registrales. T 2865 ,F 33, S 8, H SS 40917, I/A 4 (15.10.18).
01 de Octubre de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 16.07.18. Objeto social: el comercio, tanto al mayor como al menor, la importaci贸n y laexportaci贸n de toda clase de productos de alimentaci贸n. Domicilio: C/ IRURTZUN 55, POL. 103. (LEZO). Capital: 3.000,00 Euros.Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CONSULTORES SAYMA SOCIEDAD ANONIMA. Nombramientos. Consejero:FRANCH DE FRANCISCO JORDI;GONZALEZ RECIO OMAR;SAIZ GONZALEZ JESUS. Presidente: FRANCH DE FRANCISCOJORDI. Vicesecret.: GONZALEZ RECIO OMAR. SecreNoConsj: MENOR PEREZ JAVIER ALBERTO. Datos registrales. T 2865 , F30, S 8, H SS 40917, I/A 1 (20.09.18).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GUZMAN GASTRONOMIA SL. Nombramientos. Co.De.Ma.So:GONZALEZ RECIO OMAR. Datos registrales. T 2865 , F 32, S 8, H SS 40917, I/A 2 (21.09.18).