Actos BORME de Big Bang Sa
14 de Diciembre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 75.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 750.000,00 Euros. Datos registrales. T 37171 , F150, S 8, H B 15829, I/A 36 ( 4.12.23).
10 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 108.465,22 Euros. Resultante Suscrito: 825.000,00 Euros. Datos registrales. T 37171 , F149, S 8, H B 15829, I/A 34 ( 2.08.22).
11 de Octubre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 145.057,20 Euros. Resultante Suscrito: 933.465,22 Euros. Datos registrales. T 37171 , F149, S 8, H B 15829, I/A 33 ( 3.10.19).
02 de Agosto de 2018Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 337.500,05 Euros. Datos registrales. T 37171 , F 148, S 8, H B 15829, I/A 32(24.07.18).
26 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.000.000,16 Euros. Desembolsado: 662.500,11 Euros. Resultante Suscrito: 1.078.522,42 Euros.Resultante Desembolsado: 741.022,37 Euros. Datos registrales. T 37171 , F 147, S 8, H B 15829, I/A 31 (19.01.18).
05 de Diciembre de 2017Nombramientos. CONSEJERO: CAMP PEREZ CARLES. PRESIDENTE: CAMP PEREZ CARLES. CONSEJERO: CAMP PEREZFRANCESC. SECRETARIO: CAMP PEREZ FRANCESC. CONSEJERO: CAMP PEREZ JOSEP MARIA. VICEPRESIDEN: CAMPPEREZ JOSEP MARIA. CONSEJERO: CAMP PEREZ ALBERT. VICESECRET.: CAMP PEREZ ALBERT. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DEADMINISTRACION SOCIAL. Cambio de domicilio social. AV DE EUROPA Num.13 (GRANOLLERS). Datos registrales. T 37171 ,F 146, S 8, H B 15829, I/A 29 (27.11.17).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.729.622,61 Euros. Resultante Suscrito: 78.522,26 Euros. Datos registrales. T 37171 , F147, S 8, H B 15829, I/A 30 (27.11.17).
22 de Agosto de 2012Revocaciones. ADM.UNICO: SIMBEL BV. REPR.143 RRM: PAULUS CORNELIS GERHARDUS VAN DUUREN. AUDIT.CUENT.:ABGL SLP. Nombramientos. CONSEJERO: CAMP PEREZ CARLES. PRESIDENTE: CAMP PEREZ CARLES. CONSEJERO: CAMPPEREZ FRANCESC. SECRETARIO: CAMP PEREZ FRANCESC. CONSEJERO: CAMP PEREZ JOSEP MARIA. VICEPRESIDEN:CAMP PEREZ JOSEP MARIA. CONSEJERO: CAMP PEREZ ALBERT. VICESECRET.: CAMP PEREZ ALBERT. Modificacionesestatutarias. ARTS.11,21,23:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 37171 , F 145, S 8, H B 15829, I/A 28( 9.08.12).
28 de Mayo de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.014.538,44 Euros. Desembolsado: 6.014.538,44 Euros. Resultante Suscrito: 7.808.144,87 Euros.Resultante Desembolsado: 7.808.144,87 Euros. Datos registrales. T 37171 , F 143, S 8, H B 15829, I/A 27 (17.05.12).
11 de Mayo de 2012Revocaciones. REPR.143 RRM: RENATE AGATHE BOELENS. Nombramientos. ADM.UNICO: SIMBEL BV. REPR.143 RRM:PAULUS CORNELIS GERHARDUS VAN DUUREN. Datos registrales. T 37171 , F 143, S 8, H B 15829, I/A 25 (30.04.12).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABGL SLP. Datos registrales. T 37171 , F 143, S 8, H B 15829, I/A 26 (30.04.12).
09 de Septiembre de 2010Revocaciones. REPR.143 RRM: JOHANNES HUIBERT VERSTEEG. Nombramientos. REPR.143 RRM: RENATE AGATHEBOELENS. ADM.UNICO: SIMBEL BV. Datos registrales. T 37171 , F 142, S 8, H B 15829, I/A 24 (30.08.10).