Actos BORME de Bigbang Media Sl
23 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BENET FERRAN JOSEP MARIA;ROURES LLOP JAUME. Nombramientos. Adm. Unico: BENETFERRAN JOSEP MARIA. Datos registrales. T 25719 , F 213, S 8, H M 463595, I/A 36 (16.11.23).
20 de Noviembre de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MEDIAPRODUCCION SL. Datos registrales. T 25719 , F 213, S 8,H M 463595, I/A 35 (13.11.23).
08 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROURES LLOP JAUME. Datos registrales. T 25719 , F 213, S 8, H M 463595, I/A 34 (27.04.23).
12 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: BAS LOSTAO PABLO.Datos registrales. T 25719 , F 212, S 8, H M 463595, I/A 33 ( 3.04.23).
08 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: SISTERNAS TUSELL MARIA. Datos registrales. T 25719 , F 212, S 8, H M 463595, I/A 32 ( 1.02.23).
01 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MEDIAPRODUCCION SL. Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA. Nombramientos. Adm.Solid.: BENET FERRAN JOSEP MARIA;ROURES LLOP JAUME. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:Administrador único a Administradores solidarios. Datos registrales. T 25719 , F 212, S 8, H M 463595, I/A 31 (25.01.23).
07 de Octubre de 2022Otros conceptos: El Socio Unico "Imagina Media Audiovisual SA" ha cambiado su denominación por la de "GRUP MEDIAPRO SA".Datos registrales. T 25719 , F 211, S 8, H M 463595, I/A 30 (30.09.22).
17 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: RIERA FERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 25719 , F 211, S 8, H M 463595, I/A 29 (10.03.22).
10 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ESPESO LAURA. Datos registrales. T 25719 , F 211, S 8, H M 463595, I/A 28 (2.11.21).
14 de Octubre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SA. Datos registrales. T 25719 ,F 211, S 8, H M 463595, I/A 27 ( 6.10.21).
23 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: BENITO RAMOS CARLOS. Datos registrales. T 25719 , F 210, S 8, H M 463595, I/A 26 (16.09.21).
17 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: ELIAS LISBONA BERNAT;ARNAEZ COCO DANIEL;BENITO RAMOS CARLOS;PONS TUBIOJAVIER;MENDEZ ZORI JAVIER;FERNANDEZ ESPESO LAURA. Datos registrales. T 25719 , F 209, S 8, H M 463595, I/A 25(10.06.21).
15 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: CARDENAL CARRO MIGUEL. Datos registrales. T 25719 , F 207, S 8, H M 463595, I/A 24 ( 8.03.21).
14 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ENSESA VIÑAS JOSEP;KIRPAL ADRIAN. Datos registrales. T 25719 , F 205, S 8, H M 463595, I/A23 ( 7.08.20).
27 de Enero de 2020Revocaciones. Apoderado: CARULLO ALBERTO NICOLA;CARULLO ALBERTO NICOLA. Datos registrales. T 25719 , F 202, S 8,H M 463595, I/A 21 (20.01.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROURES LLOP JAUME;BENET FERRAN JOSEP MARIA. Apo.Manc.: RUIZ DE GAUNA PELAEZJUAN;FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO;ABANS IGLESIAS EVA MARIA;RUBIO GARCIA JOSE LUIS;FERNANDEZ TALLONMARI CARMEN;SOLER CANTALOSELLA JORDI;MENDEZ ZORI JAVIER;DIEZ GAMBOA IRANTZU;DE LA FUENTE RUZFRANCISCO JOSE;JIMENEZ GOMEZ MARIA PILAR;VIA MELICH ALBERTO;FERNANDEZ ESPESO LAURA;D'AMATO JOSENICOLAS;ANGLADA DORDAL CARME;ANGUERA ARMENGOL LAURA;SISTERNAS TUSELL MARIA;PANIGHI ALEJANDRACLAUDIA;VAZQUEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 25719 , F 203, S 8, H M 463595, I/A 22 (20.01.20).
17 de Enero de 2020Declaración de unipersonalidad. Socio único: MEDIAPRODUCCION SL. Datos registrales. T 25719 , F 202, S 8, H M 463595, I/A20 (10.01.20).
17 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. CTRA DE FUENCARRAL A ALCOBENDAS Km 24 - EDIFICIO G (MADRID). Datos registrales. T25719 , F 202, S 8, H M 463595, I/A 19 (10.10.19).
12 de Agosto de 2019Nombramientos. Apoderado: CARULLO ALBERTO NICOLA. Datos registrales. T 25719 , F 201, S 8, H M 463595, I/A 18 (5.08.19).
15 de Marzo de 2018Cambio de domicilio social. CTRA DE FUENCARRAL A ALCOBENDAS, NUMERO 24 Km - E (ALCOBENDAS). Datos registrales.T 25719 , F 201, S 8, H M 463595, I/A 17 ( 7.03.18).
10 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MEDIAPRO CONTENIDOS SL. Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA. Nombramientos.Adm. Unico: MEDIAPRODUCCION SL. Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA. Datos registrales. T 25719 , F 201, S 8, H M463595, I/A 16 (26.04.17).
20 de Junio de 2016Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/ALMAGRO 3 4º - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 25719 , F 201, S 8, H M 463595, I/A 15 ( 9.06.16).
01 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROURES LLOP JAUME. Datos registrales. T 25719 , F 141, S 8, H M 463595, I/A 14 (23.03.16).
16 de Marzo de 2016Cambio de domicilio social. C/ VIRGILIO 2 - CIUDAD DE LA IMAGEN (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 25719 , F140, S 8, H M 463595, I/A 13 ( 9.03.16).
15 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: CARULLO ALBERTO NICOLA. Datos registrales. T 25719 , F 140, S 8, H M 463595, I/A 12 (8.03.16).
14 de Marzo de 2016Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ANICAR 61 SL. Representan: CARULLO ALBERTONICOLA. Nombramientos. Adm. Unico: MEDIAPRO CONTENIDOS SL. Representan: BENET FERRAN JOSEP MARIA.Ampliación de capital. Capital: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 25719 , F 139, S 8,H M 463595, I/A 11 ( 7.03.16).
16 de Julio de 2015Revocaciones. Apoderado: CORTES MCALLISTER MARIANA. Datos registrales. T 25719 , F 139, S 8, H M 463595, I/A 10 (
15 de Julio de 2015Declaración de unipersonalidad. Socio único: ANICAR 61 SL. Datos registrales. T 25719 , F 138, S 8, H M 463595, I/A 9 (7.07.15).
13 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ORTEGA PEREZ VILLANUEVA ISABEL. Consejero: CARULLO ALBERTO;CORTES MARIANA.Presidente: CARULLO ALBERTO. Con.Delegado: CARULLO ALBERTO. Consejero: SANTAMARIA BARRIO ANGEL. Secretario:RODRIGUEZ VALDERAS MARIO. Nombramientos. Adm. Unico: ANICAR 61 SL. Representan: CARULLO ALBERTO NICOLA.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T25719 , F 138, S 8, H M 463595, I/A 8 ( 3.07.15).
26 de Noviembre de 2014Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 7& EL NOMBRAMIENTO DE "PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL" COMO AUDITOR DE CUENTAS, SIENDO LO CORRECTO "ERNST & YOUNG SL". Datos registrales. T 25719 , F138, S 8, H M 463595, I/A 7 (11.03.14).
18 de Marzo de 2014Revocaciones. Auditor: LEALTADIS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORESSL. Datos registrales. T 25719 , F 138, S 8, H M 463595, I/A 7 (11.03.14).
29 de Abril de 2013Nombramientos. Auditor: LEALTADIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25719 , F 138, S 8, H M 463595, I/A 6 (19.04.13).
05 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTANA PRADERA DAMASO;CANAL FACTORIA DE FICCION SA. Representan: RODRIGUEZVALDERAS MARIO. Nombramientos. Consejero: SANTAMARIA BARRIO ANGEL. Datos registrales. T 25719 , F 137, S 8, H M463595, I/A 5 (24.05.12).
06 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: CORTES MCALLISTER MARIANA. Datos registrales. T 25719 , F 136, S 8, H M 463595, I/A 4(27.07.09).
08 de Abril de 2009Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 25719 , F 136, S 8, H M 463595, I/A 3 (27.03.09).