Actos BORME de Bigmat Stores Sl
14 de Julio de 2022Nombramientos. Consejero: VALLES MONREAL CRISTIAN. Cons.Del.Man: VALLES MONREAL CRISTIAN. Datos registrales. T31962 , F 205, S 8, H M 575245, I/A 21 ( 7.07.22).
26 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO.Apo.Man.Soli: LARA SEIJO FRANCISCO DE ASIS;SANCHEZ SANCHEZ MARCOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVESGRANDE MONICA;DE ANTONIO PEREZ PABLO;GARCIA SANZ RICARDO. Datos registrales. T 31962 , F 205, S 8, H M 575245,I/A 20 (19.05.22).
16 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: FONTECHA DIEZ CONSUELO. Cons.Del.Man: FONTECHA DIEZ CONSUELO. Datos registrales. T31962 , F 205, S 8, H M 575245, I/A 19 ( 9.02.22).
14 de Enero de 2021Nombramientos. Consejero: ESCODA GIRONES JORDI. Cons.Del.Man: ESCODA GIRONES JORDI. Consejero: FONTECHA DIEZCONSUELO. Cons.Del.Man: FONTECHA DIEZ CONSUELO. Datos registrales. T 31962 , F 204, S 8, H M 575245, I/A 18 ( 7.01.21).
31 de Agosto de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ESCODA GIRONES JORDI;FONTECHA DIEZ CONSUELO.Cons.Del.Man: ESCODA GIRONES JORDI;FONTECHA DIEZ CONSUELO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LARA SEIJOFRANCISCO DE ASIS;SANCHEZ SANCHEZ MARCOS. Datos registrales. T 31962 , F 204, S 8, H M 575245, I/A 17 (24.08.20).
14 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: OLIVER RODRIGUEZ-LOSADA SONIA. Apo.Manc.: OLIVER RODRIGUEZ-LOSADA SONIA. Datosregistrales. T 31962 , F 203, S 8, H M 575245, I/A 16 ( 7.08.19).
07 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO. Cons.Del.Man: MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO.Secretario: VI脩AS GONZALEZ-ZAERA PEDRO. Presidente: MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero:JIMENEZ BAEZA SALVADOR. Cons.Del.Man: JIMENEZ BAEZA SALVADOR. Secretario: GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER.Presidente: VI脩AS GONZALEZ-ZAERA PEDRO. Datos registrales. T 31962 , F 203, S 8, H M 575245, I/A 15 (31.07.19).
12 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO. Datosregistrales. T 31962 , F 202, S 8, H M 575245, I/A 14 ( 5.03.19).
13 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: ALVES GRANDE MONICA;DE ANTONIO PEREZ PABLO;OLIVER RODRIGUEZ-LOSADA SONIA.Datos registrales. T 31962 , F 202, S 8, H M 575245, I/A 13 ( 5.12.18).
05 de Diciembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 97.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 31962 , F 128,S 8, H M 575245, I/A 12 (28.11.18).
03 de Diciembre de 2018Nombramientos. Cons.Del.Man: NOLASCO ALDEGUER DAVID. Datos registrales. T 31962 , F 128, S 8, H M 575245, I/A 11(26.11.18).
30 de Noviembre de 2018Nombramientos. Consejero: NOLASCO ALDEGUER DAVID. Datos registrales. T 31962 , F 127, S 8, H M 575245, I/A 9 (23.11.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLIVER RODRIGUEZ-LOSADA SONIA. Datos registrales. T 31962 , F 128, S 8, H M 575245, I/A10 (23.11.18).
28 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: TORRES ROSALES JOSE RODRIGO. Apo.Sol.: TORRES ROSALES JOSE RODRIGO. Apo.Man.Soli:TORRES ROSALES JOSE RODRIGO. Datos registrales. T 31962 , F 127, S 8, H M 575245, I/A 8 (20.08.18).
19 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVES GRANDE MONICA;DE ANTONIO PEREZ PABLO;TORRES ROSALES JOSE RODRIGO.Datos registrales. T 31962 , F 127, S 8, H M 575245, I/A 7 (12.04.18).
16 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: ALVES GRANDE MONICA. Apo.Sol.: ALVES GRANDE MONICA;DE ANTONIO PEREZ PABLO.Apo.Manc.: DE ANTONIO PEREZ PABLO;TORRES ROSALES JOSE RODRIGO. Apo.Sol.: TORRES ROSALES JOSE RODRIGO.Datos registrales. T 31962 , F 126, S 8, H M 575245, I/A 6 ( 9.01.18).
24 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA VILLA VEGA LORENZO. Presidente: DE LA VILLA VEGA LORENZO. Consejero: VILASOTERO XESUS MARIA;FERNANDEZ ROIG ALDINO. Cons.Del.Man: DE LA VILLA VEGA LORENZO;VILAS OTERO XESUS MARIA.Secretario: MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GARCIA GONZALEZ FRANCISCO
06 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: FERNANDEZ ROIG ALDINO. Datos registrales. T 31962 , F 124, S 8, H M 575245, I/A 4(29.07.14).
09 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRIETO IBA脩EZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 31962 , F 124, S 8, H M 575245, I/A 3 (1.04.14).
05 de Marzo de 2014Nombramientos. Cons.Del.Man: DE LA VILLA VEGA LORENZO;MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO;FONTECHA DIEZCONSUELO;VILAS OTERO XESUS MARIA;ESCODA GIRONES JORDI;FERNANDEZ ROIG ALDINO. Datos registrales. T 31962 , F124, S 8, H M 575245, I/A 2 (26.02.14).
27 de Febrero de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.01.14. Objeto social: 1.- La compra, venta, distriBuci贸n y comercializaci贸n de toda clasede materiales de construcci贸n. 2.- La explotaci贸n y el desarroll贸 de la marca comercial BigMat. Quedan excluidas del objeto soial todasaquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales o de capit谩l ... Domicilio: AVDA DE LOS PIRINEOS 7 1&(SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Capital: 100.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BIGMAT IBERIASA. Nombramientos. Consejero: DE LA VILLA VEGA LORENZO. Presidente: DE LA VILLA VEGA LORENZO. Consejero: MORENORODRIGUEZ FRANCISCO. Secretario: MORENO RODRIGUEZ FRANCISCO. Consejero: FONTECHA DIEZ CONSUELO;VILASOTERO XESUS MARIA;ESCODA GIRONES JORDI;FERNANDEZ ROIG ALDINO. Datos registrales. T 31962 , F 121, S 8, H M575245, I/A 1 (19.02.14).