Actos BORME de Bimemara Sl
28 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA RUSO LAURA;RUVIRA GUILABERT FRANCISCO JAVIER;RAMON RIVES CARMELO;GADEARAMOS MARIA LOURDES;MELLADO POMARES VICTOR MANUEL. Apo.Manc.: MELLADO POMARES VICTOR MANUEL;GARCIARUSO LAURA;RUVIRA GUILABERT FRANCISCO JAVIER;RAMON RIVES CARMELO. Apo.Man.Soli: MELLADO POMARES VICTORMANUEL;GARCIA RUSO LAURA;RUVIRA GUILABERT FRANCISCO JAVIER;RAMON RIVES CARMELO;GADEA RAMOS MARIALOURDES. Datos registrales. T 2129 , F 126, S 8, H A 48445, I/A 14 (20.04.21).
26 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: PASTOR BOTELLA VICENTE. Datos registrales. T 2129 , F 126, S 8, H A 48445, I/A 13 (16.04.21).
23 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PASTOR BOTELLA VICENTE. Nombramientos. Consejero: MELLADO POMARES VICTORMANUEL;RUVIRA GUILABERT FRANCISCO JAVIER;RAMON RIVES CARMELO. Presidente: MELLADO POMARES VICTORMANUEL. Secretario: RUVIRA GUILABERT FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 2129 , F 126, S 8, H A 48445, I/A 12 (14.04.21).
22 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRAS BELTRAN ELIODORO. Nombramientos. Adm. Unico: PASTOR BOTELLA VICENTE.Datos registrales. T 2129 , F 99, S 8, H A 48445, I/A 11 (11.05.20).
09 de Abril de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.039.905,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.665.900,00 Euros. Datos registrales. T 2129 ,F 99, S 8, H A 48445, I/A 10 (23.03.12).