Actos BORME de Biocarburantes De Castilla Y Leon Sa
20 de Octubre de 2023Reelecciones. Cons.Del.Man: MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR;GARCIA DE ALVEAR IGNACIO;VALLESPIR DE GREGORIOANTONIO JOSE. Datos registrales. T 441 , F 61, S 8, H SA 8436, I/A 73 (13.10.23).
04 de Agosto de 2023Reelecciones. Consejero: VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE. Presidente: VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE.Consejero: GARCIA DE ALVEAR IGNACIO. Vicepresid.: GARCIA DE ALVEAR IGNACIO. Consejero: MARTOS BARRIONUEVOSALVADOR. Vicesecret.: MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR. Datos registrales. T 441 , F 60, S 8, H SA 8436, I/A 72 (24.07.23).
28 de Abril de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 441 , F 60, S 8, H SA 8436, I/A 71 (19.04.23).
26 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SIMON CABO CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: SERRANO DE PABLOVALDENEBRO LUIS. Datos registrales. T 441 , F 60, S 8, H SA 8436, I/A 69 (15.02.21).
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9º BIS. PRENDA DE LAS ACCIONES. En caso deprenda de las acciones, todos losderechos económicos y políticos inherentes a las acciones corresponderán al propietario de dichas acciones. Sin embargo, el ejerciciode los derechos económicos y políticos inherentes a las acciones corresponderá. Datos registrales. T 441 , F 60, S 8, H SA 8436, I/A70 (17.02.21).
04 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 441 , F 59, S 8, H SA 8436, I/A 68 (29.01.21).
03 de Abril de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL;DELOITTE SL. Datos registrales. T 441 , F 59, S 8, H SA 8436, I/A 66 (25.03.19).
Nombramientos. Cons.Del.Man: MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR;GARCIA DE ALVEAR IGNACIO;VALLESPIR DEGREGORIO ANTONIO JOSE. Otros conceptos: REVOCAR la delegación de facultades mancomunadas por parte del Consejo de
23 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MARTIN ALBERTO;SANCHEZ DE IBARGUEN ESQUIVIAS IGNACIO. Apo.Manc.:VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 441 , F 59, S 8, H SA 8436, I/A 65 (16.11.18).
26 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE;MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR.Nombramientos. SecreNoConsj: SIMON CABO CARLOS. Consejero: VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE. Presidente:VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE. Consejero: GARCIA DE ALVEAR IGNACIO. Vicepresid.: GARCIA DE ALVEARIGNACIO. Consejero: MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR. Vicesecret.: MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR. Apo.Sol.: GARCIADE ALVEAR IGNACIO;MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR;VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE. Otros conceptos:Modificados los artículos 11º, 13º, 17º, 18º, 22º y 23º de los Estatutos Sociales Cambio del Organo de Administración: Administradoresmancomunados a Consejo de administración. Datos registrales. T 441 , F 55, S 8, H SA 8436, I/A 64 (22.10.18).
06 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ALONSO JUAN-MARIA. Datos registrales. T 441 , F 55, S 8, H SA 8436, I/A 63 (26.09.17).
26 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABENGOA BIOENERGIA SA. Nombramientos. Adm. Mancom.: VALLESPIR DE GREGORIOANTONIO JOSE;MARTOS BARRIONUEVO SALVADOR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradorúnico a Administradores mancomunados. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11º, 13º, 17º, 18º, 22º y 23º DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Datos registrales. T 440 , F 160, S 8, H SA 8436, I/A 61 (14.06.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES. Apo.Sol.: BALBOA LINARES SALVADOR;CORREAPORTILLO SANTIAGO. Apo.Manc.: DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES. Apoderado: SOTO MARTIN JOSE ANTONIO.Apo.Man.Soli: MORILLO LEON FRANCISCO-ANTONIO;CARMONA BOSCH ALBERTO;SOTO MARTIN JOSE ANTONIO;PORRASSERRANO SANDRA;CORREDERA CATALAN FELIX;DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES. Apo.Manc.: PORRAS SERRANOSANDRA. Otros conceptos: REVOCADO el poder conferido a DON EDUARDO GARCIA CAMPOS titular del DNI número07973036-V, por medio de escritura de pública de fecha 15 de mayo de 2013 otorgada ante el notario do Sevilla D. José RuizGranados con el número 1429 de su protocolo, causando la inscripción 44ª. Datos registrales. T 440 , F 160, S 8, H SA 8436, I/A 62(14.06.17).
15 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA CAMPOS EDUARDO. Datos registrales. T 440 , F 159, S 8, H SA 8436, I/A 60 ( 6.06.17).
08 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SALAS MONTALVO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 440 , F 156, S 8, H SA 8436, I/A 54(19.04.16).
02 de Junio de 2017Ampliación de capital. Suscrito: 100,00 Euros. Desembolsado: 100,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.000.100,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 25.000.100,00 Euros. Datos registrales. T 440 , F 158, S 8, H SA 8436, I/A 59 (25.05.17).
02 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CALDERERO SUAREZ DANIEL. Datos registrales. T 440 , F 157, S 8, H SA 8436, I/A 57 (13.12.16).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 440 , F 157, S 8, H SA 8436, I/A 58 (13.12.16).
13 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: CALDERERO SUAREZ DANIEL. Datos registrales. T 440 , F 157, S 8, H SA 8436, I/A 55 ( 4.05.16).
Revocaciones. Apoderado: NOVALES MONTANER GERARDO. Apo.Sol.: BERMUDEZ MENCHON MERCEDES. Apo.Man.Soli:CARMONA SEGURA MANUEL. Datos registrales. T 440 , F 157, S 8, H SA 8436, I/A 56 ( 4.05.16).
29 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES;VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE.Presidente: DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES. Consejero: BLANCO PARRA TOMAS. Nombramientos. Adm. Unico:ABENGOA BIOENERGIA SA. Otros conceptos: Modificacion parcial de estatutos sociales. Cambio del Organo de Administración:Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 440 , F 156, S 8, H SA 8436, I/A 54 (19.04.16).
21 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 440 , F 156, S 8, H SA 8436, I/A 53 (13.04.16).
29 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: GAROZ NEIRA JAVIER;MORILLO LEON FRANCISCO-ANTONIO;GARCIA ALVEARIGNACIO;CARMONA BOSCH ALBERTO;SOTO MARTIN JOSE ANTONIO;BOLET OLIVELLA JOAN;PORRAS SERRANOSANDRA;CORREDERA CATALAN FELIX;DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES;GARCIA MARTIN ALBERTO;BLANCOPARRA TOMAS;CARMONA SEGURA MANUEL;SANCHEZ DE IBARGUEN ESQUIVIAS IGNACIO;PUENTES ALONSO ANTONIO-JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE;MARTOS BARRIONUEVOSALVADOR;MORILLO LEON FRANCISCO-ANTONIO;CARMONA BOSCH ALBERTO;SOTO MARTIN JOSE ANTONIO;BOLETOLIVELLA JOAN;PORRAS SERRANO SANDRA;CORREDERA CATALAN FELIX;DE MULA GONZALEZ DE RIANCHOGINES;GARCIA MARTIN ALBERTO;BLANCO PARRA TOMAS;CARMONA SEGURA MANUEL;SANCHEZ DE IBARGUENESQUIVIAS IGNACIO;MARZO GOMEZ CARMEN. Datos registrales. T 440 , F 154, S 8, H SA 8436, I/A 51 (16.12.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: GAROZ NEIRA JAVIER. Apo.Manc.: GAROZ NEIRA JAVIER;GAROZ NEIRA JAVIER. Nombramientos.Apo.Manc.: VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE;PORRAS SERRANO SANDRA. Otros conceptos: REVOCADO el poderconferido a DON IGNACIO GARCIA ALVEAR que causó la inscripcion 45&. Datos registrales. T 440 , F 155, S 8, H SA 8436, I/A 52(16.12.15).
14 de Diciembre de 2015Nombramientos. Consejero: BLANCO PARRA TOMAS. Datos registrales. T 440 , F 153, S 8, H SA 8436, I/A 50 ( 4.12.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GAROZ NEIRA JAVIER. Presidente: GAROZ NEIRA JAVIER. Nombramientos. Presidente: DEMULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES. Datos registrales. T 440 , F 153, S 8, H SA 8436, I/A 50 . ( 4.12.15).
29 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BERMUDEZ MENCHON MERCEDES. Datos registrales. T 440 , F 153, S 8, H SA 8436, I/A 49 (9.07.14).
18 de Julio de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: BERMUDEZ MENCHON MERCEDES. Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO PARRA TOMAS. Datosregistrales. T 440 , F 151, S 8, H SA 8436, I/A 47 ( 4.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAROZ NEIRA JAVIER;MORILLO LEON FRANCISCO-ANTONIO;GARCIA ALVEARIGNACIO;CARMONA BOSCH ALBERTO;SOTO MARTIN JOSE ANTONIO;BOLET OLIVELLA JOAN;PORRAS SERRANOSANDRA;CORREDERA CATALAN FELIX;DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES;GARCIA MARTIN ALBERTO;BLANCOPARRA TOMAS;CARMONA SEGURA MANUEL;SANCHEZ DE IBARGUEN ESQUIVIAS IGNACIO;PUENTES ALONSO ANTONIO-JOSE. Datos registrales. T 440 , F 152, S 8, H SA 8436, I/A 48 ( 4.07.14).
04 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SALGADO LEIRADO JAVIER. Presidente: SALGADO LEIRADO JAVIER. Nombramientos.Consejero: GAROZ NEIRA JAVIER. Presidente: GAROZ NEIRA JAVIER. Datos registrales. T 335 , F 203, S 8, H SA 8436, I/A 43(21.06.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA CAMPOS EDUARDO. Otros conceptos: Se acepta la renuncia presentada a su cargo de Jefede Planta por Don Gonzalo Curiel Fernández y se revoca el apoderamiento conferido en favor de dicho señor en escrituraotorgadaante el Notario de Sevila Don José Ruiz Granados con fecha 5de Noviembre de 2.007 nº 6.847/07 de su protocolo. Datosregistrales. T 440 , F 149, S 8, H SA 8436, I/A 44 (21.06.13).
Revocaciones. Apo.Manc.: SALGADO LEIRADO JAVIER. Apo.Man.Soli: SALGADO LEIRADO JAVIER. Apo.Manc.: GARCIAALVEAR IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: GAROZ NEIRA JAVIER. Apo.Manc.: GAROZ NEIRA JAVIER;GAROZ NEIRAJAVIER. Datos registrales. T 440 , F 149, S 8, H SA 8436, I/A 45 (21.06.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: ROVIRA DELGADO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 440 , F 151, S 8, H SA 8436, I/A 46 (21.06.13).
24 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES. Nombramientos. Presidente: SALGADO LEIRADOJAVIER. Datos registrales. T 335 , F 203, S 8, H SA 8436, I/A 42 (15.01.13).
27 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: PAZ CABALLERO FRANCISCO. Apo.Manc.: PAZ CABALLERO FRANCISCO. Apo.Sol.: CURIELFERNANDEZ GONZALO. Apo.Manc.: CURIEL FERNANDEZ GONZALO. Nombramientos. Apo.Sol.: BERMUDEZ MENCHONMERCEDES. Datos registrales. T 335 , F 202, S 8, H SA 8436, I/A 41 (18.09.12).
24 de Agosto de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 335 , F 202, S 8, H SA 8436, I/A 40 ( 7.08.12).
21 de Agosto de 2012Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ABENGOA BIOENERGIA SA. Nombramientos. Consejero: SALGADOLEIRADO JAVIER. Reelecciones. Presidente: DE MULA GONZALEZ DE RIANCHO GINES. Consejero: DE MULA GONZALEZ DERIANCHO GINES;VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 335 , F 202, S 8, H SA 8436, I/A 39 ( 2.08.12).
09 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: SOTO MARTIN JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 335 , F 109, S 8, H SA 8436, I/A 37 (22.07.11).
Reelecciones. Auditor: PRICEWHATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 335 , F 202, S 8, H SA 8436, I/A38 (26.07.11).
01 de Febrero de 2011Reducción de capital. Importe reducción: 51.479.085,67 Euros. Resultante Suscrito: 2.121.336,68 Euros. Ampliación de capital.Suscrito: 22.878.663,32 Euros. Desembolsado: 22.878.663,32 Euros. Resultante Suscrito: 25.000.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 25.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 335 , F 108, S 8, H SA 8436, I/A 36 (21.01.11).
03 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: PRICEWHATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 335 , F 107, S 8, H SA 8436, I/A35 (19.11.10).
21 de Enero de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: MONTOYA LOPEZ ANTONIO. Nombramientos. Apo.Sol.: ROVIRA DELGADO JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 335 , F 105, S 8, H SA 8436, I/A 33 ( 5.01.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALGADO LEIRADO JAVIER;VALLESPIR DE GREGORIO ANTONIO JOSE. Apo.Manc.: GINES DEMULA GONZALEZ DE RIANCHO. Datos registrales. T 335 , F 105, S 8, H SA 8436, I/A 34 ( 5.01.10).
12 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWHATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 335 , F 104, S 8, H SA 8436, I/A32 (22.10.09).
27 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: NICOLAS BAUTISTA VALERO DE BERNABE;GUERRERO MEDINA ANDRES;EBRO PULEVA SA.SecreNoConsj: PEREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL. Revocaciones. Apo.Man.Soli: NICOLAS BAUTISTA VALERO DE BERNABE.Nombramientos. SecreNoConsj: SALAS MONTALVO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 335 , F 104, S 8, H SA 8436, I/A 31 (8.10.09).
11 de Agosto de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: RUIZ-GALVEZ AGOSTI MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: HERRERO RODRIGUEZ CRISTINA. Datosregistrales. T 335 , F 104, S 8, H SA 8436, I/A 30 (24.07.09).
24 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FELIX SANTOS CARRASCOSA. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ ALVAREZ MIGUELANGEL. Datos registrales. T 335 , F 104, S 8, H SA 8436, I/A 29 ( 9.07.09).