Buscador CIF Logo

Actos BORME Bioconservacion Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bioconservacion Sa

Actos BORME Bioconservacion Sa - A81412280

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Bioconservacion Sa con CIF A81412280

馃敊 Perfil de Bioconservacion Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Bioconservacion Sa

06 de Noviembre de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 551.028,32 Euros. Desembolsado: 551.028,32 Euros. Resultante Suscrito: 965.481,41 Euros.Resultante Desembolsado: 965.481,41 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 491.456,68 Euros. Desembolsado: 491.459,68 Euros.Resultante Suscrito: 1.456.938,08 Euros. Resultante Desembolsado: 1.456.941,08 Euros. Datos registrales. T 48976 , F 151, S 8, HB 179156, I/A 39 (26.10.23).

24 de Octubre de 2023
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PLETA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 43347 , F 40, S 8, H B 179156, I/A 38 (16.10.23).

11 de Abril de 2023
Revocaciones. APODERAD.SOL: MURCIANO BRONCHAL JOSE MARIA. Nombramientos. APODERAD.SOL: MURCIANOBRONCHAL JOSE MARIA. Datos registrales. T 43347 , F 39, S 8, H B 179156, I/A 37 (31.03.23).

30 de Noviembre de 2022
Revocaciones. V-SEC NO CON: DONADEU GARCIA NIETO GUILLERMO. Datos registrales. T 43347 , F 38, S 8, H B 179156, I/A36 (22.11.22).

31 de Marzo de 2022
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CLAVERA CALVET ALBERT;SAUD AL AYOUB. Nombramientos. CONSEJERO: MIJBIL ALAYOUB;ABDULATIF AL AYOUB;SAUD AL AYOUB;ALBA RIPOLLES JOSE. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 246.633,19Euros. Resultante Suscrito: 414.453,09 Euros. Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO ELACCIONISTA UNICO DON ABDUL AZIZ AL AYOUB. Datos registrales. T 41441 , F 30, S 8, H B 179156, I/A 34 (24.03.22).

Nombramientos. PRESIDENTE: SAUD AL AYOUB. VICEPRESIDEN: ABDULATIF AL AYOUB. SECR.NO CONS: ROJI BUQUERASJOSE MARIA. V-SEC NO CON: DONADEU GARCIA NIETO GUILLERMO. APODERAD.SOL: CLAVERA CALVETALBERT;MURCIANO BRONCHAL JOSE MARIA;SAUD AL AYOUB;ABDULATIF AL AYOUB. Datos registrales. T 43347 , F 35, S 8,H B 179156, I/A 35 (24.03.22).

16 de Marzo de 2022
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CONVERSION YRENUMERACION DE ACCIONES. Otros conceptos: EMISION Y ENTREGA DE TITULOS MULTIPLES REPRESENTATIVOS DELA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 41441 , F 30, S 8, H B 179156, I/A 33 ( 9.03.22).

05 de Abril de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PLETA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41441 , F 29, S 8, H B 179156, I/A 32 (24.03.21).

19 de Febrero de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 41441 ,F 29, S 8, H B 179156, I/A 31 (11.02.21).

20 de Noviembre de 2020
Modificaciones estatutarias. ADICION DEL ARTICULO 19 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 41441 , F 28, S 8, H B 179156, I/A 29 (13.11.20).

Revocaciones. ADM.UNICO: CLAVERA CALVET ALBERT. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CLAVERA CALVET ALBERT;SAUDAL AYOUB. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 41441 , F 29, S 8, H B 179156, I/A 30 (13.11.20).

19 de Diciembre de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PLETA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41441 , F 28, S 8, H B 179156, I/A 28 (10.12.19).

11 de Diciembre de 2019
Revocaciones. ADM.UNICO: MORENO CRISTOBAL VICTOR. Nombramientos. ADM.UNICO: CLAVERA CALVET ALBERT.Datos registrales. T 41441 , F 28, S 8, H B 179156, I/A 27 (28.11.19).

18 de Enero de 2019
Cambio de domicilio social. CL VAPOR NUM.10-12,POLIGONO INDUSTRIAL EL REGAS (GAVA). Datos registrales. T 41441 , F27, S 8, H B 179156, I/A 26 (10.01.19).

14 de Febrero de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PLETA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41441 , F 27, S 8, H B 179156, I/A 25 ( 6.02.18).

24 de Mayo de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PLETA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41441 , F 27, S 8, H B 179156, I/A 24 (15.05.17).

18 de Noviembre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PLETA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41441 , F 27, S 8, H B 179156, I/A 23 ( 8.11.16).

16 de Junio de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PLETA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41441 , F 26, S 8, H B 179156, I/A 22 ( 7.06.16).

15 de Julio de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PARRA GOMEZ TOMAS. Datos registrales. T 41441 , F 26, S 8, H B 179156, I/A 20 ( 7.07.14).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TOMAS PARRA GOMEZ. Datos registrales. T 41441 , F 26, S 8, H B 179156, I/A 21 ( 7.07.14).

29 de Mayo de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: DONATO MORENO NICOLAS. Datos registrales. T 41441 , F 24, S 8, H B 179156, I/A 19(22.05.14).

22 de Mayo de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: MORENO CRISTOBAL VICTOR. CONS. DELEG.: MORENO CRISTOBAL VICTOR. CONSEJERO:GELI PONS RAMON. CONS. DELEG.: GELI PONS RAMON. CONSEJERO: ABDUL AZIZ AL AYOUB;NICOLAS DONATO MORENO.CONS. DELEG.: NICOLAS DONATO MORENO. PRESIDENTE: NICOLAS DONATO MORENO. VICEPRESIDEN: GELI PONSRAMON. SECR.NO CONS: DE WEEST PRAT JORBA ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: MORENO CRISTOBAL VICTOR.Modificaciones estatutarias. ARTS.10,17,18,19,20 Y 21.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Cambio de domicilio social.AV DIAGONAL Num.474 P.6 PTA.3 (BARCELONA). Datos registrales. T 41441 , F 23, S 8, H B 179156, I/A 18 (15.05.14).

30 de Abril de 2014
Revocaciones. SECR.NO CONS: CASANOVAS COLOMER IGNASI. Nombramientos. SECR.NO CONS: DE WEEST PRATJORBA ANTONIO. Datos registrales. T 41441 , F 23, S 8, H B 179156, I/A 17 (22.04.14).

22 de Febrero de 2013
Revocaciones. PRESIDENTE: MORENO CRISTOBAL VICTOR. Nombramientos. PRESIDENTE: NICOLAS DONATO MORENO.VICEPRESIDEN: GELI PONS RAMON. Datos registrales. T 41441 , F 23, S 8, H B 179156, I/A 16 (12.02.13).

06 de Julio de 2012
Nombramientos. APODERADO: ABEIJON SORIANO CARLOS. Datos registrales. T 41441 , F 22, S 8, H B 179156, I/A 15(27.06.12).

19 de Enero de 2012
Revocaciones. APODERADO: RECIO MARTIN FRANCISCO. SECRETARIO: GELI PONS RAMON. Nombramientos. SECR.NOCONS: CASANOVAS COLOMER IGNASI. Datos registrales. T 41441 , F 21, S 8, H B 179156, I/A 14 (10.01.12).

14 de Junio de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: GABRIELLE GIUSTO. VICEPRESIDEN: GABRIELLE GIUSTO. CONS. DELEG.: GABRIELLEGIUSTO. Nombramientos. CONSEJERO: NICOLAS DONATO MORENO. CONS. DELEG.: NICOLAS DONATO MORENO. Datos

30 de Septiembre de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: MORENO CRISTOBAL VICTOR. PRESIDENTE: MORENO CRISTOBAL VICTOR. CONS. DELEG.:MORENO CRISTOBAL VICTOR. CONSEJERO: GELI PONS RAMON. SECRETARIO: GELI PONS RAMON. CONS. DELEG.: GELIPONS RAMON. CONSEJERO: GABRIELE GIUSTO. VICEPRESIDEN: GABRIELE GIUSTO. CONS. DELEG.: GABRIELE GIUSTO.CONSEJERO: ABDUL AZIZ AL AYOUB. Nombramientos. CONSEJERO: MORENO CRISTOBAL VICTOR. PRESIDENTE:MORENO CRISTOBAL VICTOR. CONS. DELEG.: MORENO CRISTOBAL VICTOR. CONSEJERO: GELI PONS RAMON.SECRETARIO: GELI PONS RAMON. CONS. DELEG.: GELI PONS RAMON. CONSEJERO: GABRIELLE GIUSTO. VICEPRESIDEN:

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n