Actos BORME de Biocontrol Technologies Sl
07 de Septiembre de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ACTIVA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 43241 , F 155, S 8, H B295205, I/A 24 (31.08.22).
08 de Julio de 2021Revocaciones. CONSEJERO: REGLERO SANCHEZ JESUS JAVIER. Nombramientos. CONSEJERO: RESA CAPITAL SL.REPR.143 RRM: REGLERO SANCHEZ JESUS JAVIER. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 13.- CONVOCATORIA.ARTICULO 14.- ASISTENCIA Y REPRESENTACION. ARTICULO 18.- CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T40655 , F 130, S 8, H B 295205, I/A 23 (30.06.21).
01 de Septiembre de 2020Nombramientos. CONS.DEL.SOL: PEREMIQUEL LLUCH FRANCESC. Datos registrales. T 40655 , F 130, S 8, H B 295205, I/A 21(24.08.20).
Revocaciones. CONSEJERO: COTXARREA VILAPLANA LURDES. Datos registrales. T 40655 , F 130, S 8, H B 295205, I/A 22(24.08.20).
19 de Agosto de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: PEREMIQUEL LLUCH FRANCESC. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ACTIVA AUDITORIA &CONSULTORIA SLP. CONSEJERO: PEREMIQUEL LLUCH FRANCESC. PRESIDENTE: PEREMIQUEL LLUCH FRANCESC.CONSEJERO: COTXARREA VILAPLANA LURDES;REGLERO SANCHEZ JESUS JAVIER;CABANI MASSIP JAUME. SECR.NOCONS: BUXEDA FORASTE JOEL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 20.- RETRIBUCION. Datos registrales. T 40655 , F129, S 8, H B 295205, I/A 20 (12.08.20).
08 de Enero de 2020Cambio de domicilio social. AV DE MADRID NUM.215-217 ENTRESUELO A (BARCELONA). Datos registrales. T 40655 , F 129,S 8, H B 295205, I/A 19 (30.12.19).
11 de Agosto de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.388,10 Euros. Resultante Suscrito: 14.261,80 Euros. Modificaciones estatutarias. ART.6:
02 de Febrero de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ACTIVA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 40655 , F 127, S 8, H B295205, I/A 17 (25.01.17).
25 de Marzo de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABANTE PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40655 , F 127, S 8, H B 295205, I/A 16(17.03.15).
03 de Noviembre de 2014Revocaciones. CONSEJERO: PEREMIQUEL LLUCH FRANCESC. PRESIDENTE: PEREMIQUEL LLUCH FRANCESC.CONSEJERO: RIVAS ANTON MARTIN;TRILLAS GAY MARIA ISABEL. Nombramientos. ADM.UNICO: PEREMIQUEL LLUCHFRANCESC. Datos registrales. T 40655 , F 127, S 8, H B 295205, I/A 15 (27.10.14).
07 de Mayo de 2014Revocaciones. SECR.NO CONS: TORRES LOZANO CRISTINA. Datos registrales. T 40655 , F 127, S 8, H B 295205, I/A 14(28.04.14).
04 de Septiembre de 2013Revocaciones. CONSEJERO: CASANOVA FERNANDEZ EVA. Nombramientos. CONSEJERO: TRILLAS GAY MARIA ISABEL.Datos registrales. T 40655 , F 126, S 8, H B 295205, I/A 12 (28.08.13).
Revocaciones. SECR.NO CONS: MORAGAS MONTESERIN MARIA JOSE. Nombramientos. SECR.NO CONS: TORRESLOZANO CRISTINA. Datos registrales. T 40655 , F 126, S 8, H B 295205, I/A 13 (28.08.13).
27 de Diciembre de 2010Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABANTE PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40655 , F 126, S 8, H B 295205, I/A 11(15.12.10).
20 de Noviembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.014,02 Euros. Resultante Suscrito: 11.663,28 Euros. Datos registrales. T 40655 , F 123, S 8, H B295205, I/A 9 ( 9.11.09).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 210,42 Euros. Resultante Suscrito: 11.873,70 Euros. Datos registrales. T 40655 , F 125, S 8, H B295205, I/A 10 ( 9.11.09).