Actos BORME de Biogen Spain Sl
26 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: PARALERA CAZORLA MERCEDES. Nombramientos. Apoderado: PEREIRA SILVA CHRISTIANO.Datos registrales. T 37436 , F 120, S 8, H M 287637, I/A 79 (18.12.23).
24 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: LAWSON FREDERICK. Cons.Del.Sol: LAWSON FREDERICK. Presidente: WERNER DR. SCHMIDTWOFRAM. Nombramientos. Consejero: PEREIRA SILVA CHRISTIANO. Presidente: PEREIRA SILVA CHRISTIANO. Datosregistrales. T 37436 , F 117, S 8, H M 287637, I/A 77 (17.01.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA SERGIO. Nombramientos. Apoderado: PEREIRA SILVA CHRISTIANO.Datos registrales. T 37436 , F 118, S 8, H M 287637, I/A 78 (17.01.23).
20 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: FRIEDL-NADERER JOHANNA. Presidente: FRIEDL-NADERER JOHANNA. Nombramientos.Consejero: WERNER DR. SCHMIDT WOFRAM. Presidente: WERNER DR. SCHMIDT WOFRAM. Datos registrales. T 37436 , F 117,S 8, H M 287637, I/A 76 (13.06.22).
23 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 37436 , F 116, S 8, H M 287637,I/A 75 (16.02.22).
22 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: GOMEZ LOPE JUAN MANUEL;CENICEROS MATEO FRANCISCO JAVIER;AZPILICUETA GOLDARAZEDUARDO EMILIO. Apo.Sol.: AZPILICUETA GOLDARAZ EDUARDO EMILIO. Nombramientos. Apo.Sol.: CRUZ GARCES MELODYANDREA. Datos registrales. T 37436 , F 116, S 8, H M 287637, I/A 74 (15.02.22).
05 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: TELLO LOPEZ AINHOA MARIA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: TELLO LOPEZ AINHOA MARIA.Apoderado: TELLO LOPEZ AINHOA MARIA. Apo.Man.Soli: TELLO LOPEZ AINHOA MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj:GONZALEZ GARCIA URSULA. Apoderado: GONZALEZ GARCIA URSULA. Datos registrales. T 37436 , F 114, S 8, H M 287637, I/A73 (27.04.21).
21 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: GOUVEIA PINTO DE AZEVEDO ANDRE. Nombramientos. Apoderado: VALLES BASILIO IGNACIO.Datos registrales. T 37436 , F 113, S 8, H M 287637, I/A 72 (14.09.20).
26 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: AZPILICUETA GOLDARAZ EDUARDO EMILIO. Datos registrales. T 37436 , F 113, S 8, H M 287637,I/A 71 (19.02.20).
23 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: COBO HERRERA DIANA. Apo.Man.Soli: SORDO JAUREGUI I脩AKI JOAQUIN. Nombramientos.Apoderado: BALACA GONZALEZ LUCIA. Datos registrales. T 37436 , F 113, S 8, H M 287637, I/A 70 (16.12.19).
03 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: MORENO GOMEZ MARIA NOELIA. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CIDRERA ANA ISABEL.Datos registrales. T 37436 , F 112, S 8, H M 287637, I/A 69 (27.08.19).
27 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: LINDER BARCESAT VALERIA ANAHI. Datos registrales. T 37436 , F 112, S 8, H M 287637, I/A 68(20.05.19).
24 de Abril de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 37436 , F 112, S 8, H M 287637,I/A 67 (15.04.19).
15 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: JORDAN SIMON PAUL. Presidente: JORDAN SIMON PAUL. Nombramientos. Consejero: FRIEDL-NADERER JOHANNA. Presidente: FRIEDL-NADERER JOHANNA. Datos registrales. T 37436 , F 111, S 8, H M 287637, I/A 66 (8.04.19).
29 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: TELLO LOPEZ AINHOA MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TELLO LOPEZ AINHOA MARIA.Datos registrales. T 37436 , F 111, S 8, H M 287637, I/A 65 (22.03.19).
22 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: AZPILICUETA GOLDARAZ EDUARDO EMILIO. Datos registrales. T 37436 , F 110, S 8, H M 287637,I/A 64 (15.01.19).
21 de Mayo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: BALLET SABRINA AVELLE. Nombramientos. Apo.Manc.: PARALERA CAZORLA MERCEDES. Apo.Sol.:LINDER BARCESAT VALERIA ANAHI. Datos registrales. T 37436 , F 110, S 8, H M 287637, I/A 63 (11.05.18).
04 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: COSTA MATEU CARLOS FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: GOUVEIA PINTO DE AZEVEDOANDRE. Datos registrales. T 31721 , F 169, S 8, H M 287637, I/A 62 (26.03.18).
14 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GARCIA MARIA MERCEDES;SEPULVEDA MOTA PEDRO;CHAUMEL FERNANDEZJORGE. Datos registrales. T 31721 , F 169, S 8, H M 287637, I/A 61 ( 6.02.18).
03 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: COSTA MATEU CARLOS FERNANDO. Datos registrales. T 31721 , F 168, S 8, H M 287637, I/A 59(26.10.17).
Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ MIRANDA SEBASTIAN. Nombramientos. Apo.Manc.: MORENO GOMEZ MARIANOELIA. Datos registrales. T 31721 , F 168, S 8, H M 287637, I/A 60 (26.10.17).
29 de Junio de 2017Otros conceptos: El Socio Unico "BIOGEN MA INC." ha cambiado de domicilio social. Datos registrales. T 31721 , F 166, S 8, H M287637, I/A 57 (20.06.17).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUES DA COSTA VALENTE MARTA. Datos registrales. T 31721 , F 166, S 8, H M 287637,I/A 58 (20.06.17).
27 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: GOYA MENDEZ ANA EVA;CASAHORRAN SEBASTIAN VICTOR MANUEL;GOYA MENDEZ ANA EVA.Datos registrales. T 31721 , F 165, S 8, H M 287637, I/A 56 (19.06.17).
11 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: GALLACHER ALLISON ROSALIND GERALDINE. Datos registrales. T 31721 , F 165, S 8, H M287637, I/A 55 ( 3.04.17).
07 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA SERGIO. Datos registrales. T 31721 , F 163, S 8, H M 287637, I/A 54(30.01.17).
06 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: TELLO LOPEZ AINHOA MARIA. Datos registrales. T 31721 , F 163, S 8, H M 287637, I/A 53(30.01.17).
05 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: GOYA MENDEZ ANA EVA. Datos registrales. T 31721 , F 162, S 8, H M 287637, I/A 52 (27.04.16).
03 de Mayo de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31721 , F 162, S 8, H M 287637,I/A 51 (25.04.16).
12 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: STEFANUTTI UMBERTO. Apo.Manc.: STEFANUTTI UMBERTO. Datos registrales. T 31721 , F 162, S8, H M 287637, I/A 50 ( 4.04.16).
14 de Marzo de 2016Otros conceptos: Rectificaci贸n de los apellidos y DNI del apoderado que caus贸 la inscripci贸n 48, siendo el correcto Victor ManuelCasahorran Sebasti谩n dni 17725971D y no Victor Manuel Sebasti谩n Casahorran. Datos registrales. T 31721 , F 161, S 8, H M287637, I/A 49 ( 7.03.16).
16 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: SEBASTIAN CASAHORRAN VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 31721 , F 161, S 8, H M287637, I/A 48 ( 4.12.15).
23 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: LACKNER THOMAS ANDREAS. Cons.Del.Sol: LACKNER THOMAS ANDREAS. Presidente:LACKNER THOMAS ANDREAS. Nombramientos. Consejero: JORDAN SIMON PAUL. Presidente: JORDAN SIMON PAUL. Datosregistrales. T 31721 , F 160, S 8, H M 287637, I/A 47 (16.09.15).
11 de Junio de 2015Otros conceptos: CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO, PASANDO A SER "Biogen Ma Inc" . Datos registrales. T31721 , F 160, S 8, H M 287637, I/A 46 ( 3.06.15).