Actos BORME de Biomasa De Cantabria Sl
22 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ ALDOMA ANNA-ROSA;ALBARRAN ALVEAR JUAN. Datos registrales. T 1201 , F 3, S8, H S 20522, I/A 32 (12.12.23).
12 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GARRIDO HALCON TELESFORO. Datos registrales. T 1201 , F 3, S 8, H S 20522, I/A 31 (29.11.23).
08 de Septiembre de 2023Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1201 , F 3, S 8, H S 20522, I/A 30 (28.08.23).
05 de Enero de 2023Modificaciones estatutarias. Se incorpora el Art铆culo 21-Bis en los Estatutos Sociales que establece el sistema de retribuci贸n de losadministradores.-. Datos registrales. T 1201 , F 3, S 8, H S 20522, I/A 29 (29.12.22).
09 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1201 , F 1, S 8, H S 20522, I/A 28(31.08.22).
20 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1201 , F 1, S 8, H S 20522, I/A 27 (11.08.20).
19 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: BERODIA FERNANDEZ ANGEL FRANCISCO. Datos registrales. T 1201 , F 1, S 8, H S 20522, I/A 26(12.03.20).
21 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORU脩A ABASCAL LUIS. Datos registrales. T 1018 , F 22, S 8, H S 20522, I/A 25 (13.02.19).
27 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1018 , F 21, S 8, H S 20522, I/A 24(19.07.17).
19 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: SANTIAGO GONZALEZ JESUS ANGEL. Datos registrales. T 1018 , F 20, S 8, H S 20522, I/A 23(12.01.17).
22 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ROMERO HERRERA JOSE LUIS;CANALES MENDIOLEAIGNACIO;RONCAL BERRUEZO JOSE MARIA;SALCINES CORREA ALFONSO. Datos registrales. T 1018 , F 19, S 8, H S 20522,I/A 21 (18.05.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ AROZAMENA GONZALO;ROMERO HERRERA JOSE LUIS;CANALES MENDIOLEAIGNACIO;RONCAL BERRUEZO JOSE MARIA;SALCINES CORREA ALFONSO. Datos registrales. T 1018 , F 20, S 8, H S 20522,I/A 22 (18.05.15).
14 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.040.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.040.000,00 Euros. Datos registrales. T 1018 , F 19, S8, H S 20522, I/A 20 ( 7.01.15).
26 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE MARIA RONCAL BERRUEZO;TELESFORO GARRIDO HALCON. Datos registrales. T 1018 , F19, S 8, H S 20522, I/A 19 (19.11.14).
05 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. 21. Bloqueo y resoluci贸n.. Datos registrales. T 1018 , F 19, S 8, H S 20522, I/A 18 (28.08.14).
20 de Agosto de 2014Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1018 , F 19, S 8, H S 20522, I/A 17(11.08.14).
17 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1018 , F 19, S8, H S 20522, I/A 16 ( 9.01.14).
12 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDIO AMBIENTE AGUA RESIDUOS Y ENERGIA DE CANTABRI. Presidente: ALVAREZRIBALAYGUA JOSE-RAMON. Consejero: GUTIERREZ NU脩EZ ELOY. Secretario: GUTIERREZ NU脩EZ ELOY. Consejero: ALVAREZRIBALAYGUA JOSE-RAMON. Cons.Del.Sol: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE-RAMON. Consejero: ALVAREZ VILLANUEVAARMANDO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Nombramientos. Adm. Solid.: ARMANDO ALVAREZ SOCIEDADANONIMA;ALVAREZ FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios.16. Duraci贸n del cargo de administrador.-. Datos registrales. T 1018 , F 18, S8, H S 20522, I/A 15 ( 4.07.13).
11 de Abril de 2013Reelecciones. Consejero: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE-RAMON. Cons.Del.Sol: ALVAREZ RIBALAYGUA JOSE-RAMON.Consejero: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Datos registrales. T 1018 , F18, S 8, H S 20522, I/A 14 ( 2.04.13).
11 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: ALVAREZ VILLANUEVA ARMANDO. Nombramientos. Presidente: ALVAREZ RIBALAYGUAJOSE-RAMON. Reelecciones. Consejero: GUTIERREZ NU脩EZ ELOY. Secretario: GUTIERREZ NU脩EZ ELOY. Datos registrales.T 1018 , F 18, S 8, H S 20522, I/A 13 ( 1.10.12).
21 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DIEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1018 , F 17, S 8, H S 20522, I/A 12(11.06.12).
11 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 1018 , F 16, S 8, H S 20522, I/A 11(30.04.12).
28 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ CAMPOS CARLOS. Datos registrales. T 1018 , F 16, S 8, H S 20522, I/A 10 (13.02.12).
05 de Septiembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 955 , F 225, S 8,H S 20522, I/A 8 (25.08.11).