Actos BORME de Biomendi Sa
10 de Diciembre de 2018Otros conceptos: Conforme lo dispuesto en el articulo 231.2 del RRM, se extiende al margen de la inscripción 60ª la nota prevista en
30 de Noviembre de 2018Otros conceptos: Se amplía el plazo máximo para el desembolso de los dividendos pasivos y se modifica el artículo 5º estatutario.
15 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: DE MORA PEREZ PABLO. Datos registrales. T 1662 , F 204, S 8, H VI 1328, I/A 59 (29.10.18).
03 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: SUAREZ CASAS LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 1497 , F 46, S 8, H VI 1328, I/A 58(20.09.18).
06 de Abril de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GES GENERICOS ESPAÑOLES LABORATORIO S.A. Datosregistrales. T 1497 , F 46, S 8, H VI 1328, I/A 57 (28.03.17).
26 de Febrero de 2016Otros conceptos: Se modifican los Estatutos sociales por los que se rige la Compañía introduciendo el nuevo articulo 18º.2, relativo ala remuneración de los administradores.- Datos registrales. T 1497 , F 45, S 8, H VI 1328, I/A 56 (10.02.16).
22 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL.Datos registrales. T 1497 , F 45, S 8, H VI 1328, I/A 55 ( 8.01.16).
23 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: PARRA VELASCO JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: PARRA VELASCO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 1497 , F 44, S 8, H VI 1328, I/A 54 (15.12.15).
24 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: MORA PEREZ IGNACIO. Datos registrales. T 1497 , F 44, S 8, H VI 1328, I/A 53 (11.09.15).
11 de Septiembre de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ALTAN PHARMA SPAIN SL. Datos registrales. T 1497 , F 42, S 8,H VI 1328, I/A 50 (24.08.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: CORCHERO ALBARRAN FELIX;SANCHEZ ROEZNILLO ROSA MARIA;CARRASCO LANCHARROMOISES. Datos registrales. T 1497 , F 43, S 8, H VI 1328, I/A 51 (24.08.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: CORCHERO ALBARRAN FELIX;STAFFORD O KELLY DONALD;ALFONSO HERRERAGUILLERMO;FRANCIS GORMAN MARK;AXEL LIEPMANN HOLGER. Datos registrales. T 1497 , F 43, S 8, H VI 1328, I/A 52(24.08.15).
31 de Julio de 2015Otros conceptos: Se ha emitido un Titulo Múltiple Nº 1 de fecha 10-6-2.105, representativo de 5.877 acciones nºs 1 a 5.877, ambosinclusive, de 1.492,07 euros de valor nominal cada una, nominativas, totalmente suscritas y desembolsadas por importe conjunto de7.269.365,04 emitidas a favor de " SPAIN PHARMA, S.A.".- Datos registrales. T 1208 , F 127, S 8, H VI 1328, I/A 40 1 (20.07.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTUZAR ANDECHAGA IGNACIO;GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL VALLE;ORTUZARGUTIERREZ MARIO. Nombramientos. Adm. Solid.: FRANCIS GORMAN MARK;ALFONSO HERRERA GUILLERMO;AXELLIEPMANN HOLGER;STAFFORD O KELLY DONALD. Otros conceptos: Se modifica el articulo 18º estatutario.- Datos registrales.T 1497 , F 41, S 8, H VI 1328, I/A 49 (20.07.15).
24 de Febrero de 2014Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datos registrales. T 1497 , F 40, S 8, H VI 1328, I/A 48(10.02.14).
21 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTUZAR ANDECHAGA IGNACIO;GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL VALLE. Nombramientos.Adm. Solid.: ORTUZAR ANDECHAGA IGNACIO;GUTIERREZ SANCHEZ MARIA DEL VALLE;ORTUZAR GUTIERREZ MARIO. Otrosconceptos: Se modifica el artículo 18º de los estatutos sociales.- Datos registrales. T 1497 , F 39, S 8, H VI 1328, I/A 45 ( 6.06.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: CORCHERO ALBARRAN FELIX;SANCHEZ ROEZNILLO ROSA MARIA;CARRASCO LANCHARROMOISES. Datos registrales. T 1497 , F 39, S 8, H VI 1328, I/A 46 ( 6.06.13).
Revocaciones. Apo.Manc.: CORCHERO ALBARRAN FELIX;ARRANZ ABASCAL JOSE IGNACIO;CORCHERO ALBARRANFELIX;ARRANZ ABASCAL JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 1497 , F 40, S 8, H VI 1328, I/A 47 ( 6.06.13).
28 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: IPARRAGUIRRE ABAD ISABEL. Datos registrales. T 1208 , F 128, S 8, H VI 1328, I/A 42 (10.11.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: CORCHERO ALBARRAN FELIX;ARRANZ ABASCAL JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 1208 , F128, S 8, H VI 1328, I/A 43 (10.11.11).
Revocaciones. Apo.Manc.: IPARRAGUIRRE ABAD ISABEL. Datos registrales. T 1497 , F 39, S 8, H VI 1328, I/A 44 (10.11.11).
17 de Junio de 2011Revocaciones. Apoderado: ALTARRIBA FIGUEREDO JORDI. Datos registrales. T 1208 , F 127, S 8, H VI 1328, I/A 41 ( 2.06.11).
10 de Junio de 2011Otros conceptos: Se amplia el plazo de máximo para el desembolso de dividendos pasivos y se modifica el artículo 5º estatutario.Datos registrales. T 1208 , F 127, S 8, H VI 1328, I/A 40 (31.05.11).
16 de Febrero de 2011Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datos registrales. T 1208 , F 127, S 8, H VI 1328, I/A 39(27.01.11).
12 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: AGUSTI SANCHEZ AUDITORES SL. Datos registrales. T 1208 , F 126, S 8, H VI 1328, I/A 38 (15.01.10).
31 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: PARRA VELASCO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1208 , F 126, S 8, H VI 1328, I/A 37 (13.07.09).
30 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: AGUSTI SANCHEZ AUDITORES SL. Datos registrales. T 1208 , F 125, S 8, H VI 1328, I/A 36 (30.12.08).