Actos BORME de Bisinco Instalaciones Industriales Y Comerciales Sa
20 de Febrero de 2019Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: ANDRES FERNANDEZ MARIA CRUZ. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ALFONSO LILLOMANUEL;ALFONSO ANDRES MARIA CRUZ. Datos registrales. T 20438 , F 72, S 8, H B 5958, I/A 16 (11.02.19).
21 de Junio de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 203.085,36 Euros. Desembolsado: 203.085,36 Euros. Resultante Suscrito: 650.257,92 Euros.Resultante Desembolsado: 650.257,92 Euros. Datos registrales. T 20438 , F 72, S 8, H B 5958, I/A 15 (14.06.18).
28 de Abril de 2017Revocaciones. AUDIT.CUENT.: FORWARD ECONOMICS SLP. Datos registrales. T 20438 , F 72, S 8, H B 5958, I/A 14 (21.04.17).
02 de Junio de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: FORWARD ECONOMICS SLP. Datos registrales. T 20438 , F 72, S 8, H B 5958, I/A 13(26.05.16).
08 de Mayo de 2013Revocaciones. ADM.UNICO: ALFONSO LILLO MANUEL. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ALFONSO LILLO MANUEL;ANDRESFERNANDEZ MARIA CRUZ. Modificaciones estatutarias. ARTS.15,27,28 Y 30.- SISTEMA RETRIBUTIVO Y ESTRUCTURA DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 20438 , F 71, S 8, H B 5958, I/A 12 (26.04.13).
29 de Julio de 2011Nombramientos. ADM.UNICO: ALFONSO LILLO MANUEL. Datos registrales. T 20438 , F 71, S 8, H B 5958, I/A 11 (19.07.11).
08 de Mayo de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 99.979,56 Euros. Desembolsado: 99.979,56 Euros. Resultante Suscrito: 447.172,56 Euros.Resultante Desembolsado: 447.172,56 Euros. Datos registrales. T 20438 , F 70, S 8, H B 5958, I/A 10 (27.04.09).