Actos BORME de Blodelqueo Sl
27 de Noviembre de 2018Extinci贸n. Datos registrales. T 33207 , F 203, S 8, H B 39332, I/A 38 (19.11.18).
30 de Agosto de 2018Cambio de domicilio social. CL METALL,6, POL.IND. LA FERRERIA (MONTCADA I REIXAC). Datos registrales. T 31397 , F 150,S 8, H B 39332, I/A 37 (22.08.18).
17 de Febrero de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: ORTIZ TORRADO MARIA BELEN. Datos registrales. T 31397 , F 150, S 8, H B 39332, I/A 36 (9.02.16).
18 de Septiembre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: VERGES TEIXIDO JORGE. CONS. DELEG.: VERGES TEIXIDO JORGE. CONSEJERO: BAS SERRACARMEN. PRESIDENTE: VERGES TEIXIDO JORGE. CONSEJERO: VERGES CAMPS ELISABET;PLANAS BAS VICTOR.SECRETARIO: PLANAS BAS VICTOR. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PLANAS BAS VICTOR;VERGES TEIXIDO JORGE.Datos registrales. T 31397 , F 149, S 8, H B 39332, I/A 35 (10.09.15).
23 de Diciembre de 2011Revocaciones. APODERADO: UNZUETA DEVESA AVELINO. Datos registrales. T 31397 , F 149, S 8, H B 39332, I/A 34(13.12.11).
08 de Julio de 2011Nombramientos. APODERADO: VERGES CAMPS ELISABETH. Datos registrales. T 31397 , F 148, S 8, H B 39332, I/A 33(29.06.11).
08 de Abril de 2011Revocaciones. SECR.NO CONS: PLANAS COMBALIA FRANCISCO. CONSEJERO: PLANAS COMBALIA FRANCISCO. CONS.DELEG.: PLANAS COMBALIA FRANCISCO. Nombramientos. CONSEJERO: PLANAS BAS VICTOR. Datos registrales. T 31397 ,F 148, S 8, H B 39332, I/A 31 (29.03.11).
Nombramientos. SECRETARIO: PLANAS BAS VICTOR. Datos registrales. T 31397 , F 148, S 8, H B 39332, I/A 32 (29.03.11).
14 de Diciembre de 2010Nombramientos. APODERADO: PLANAS BAS VICTOR. Datos registrales. T 31397 , F 147, S 8, H B 39332, I/A 30 (30.11.10).
26 de Octubre de 2010Revocaciones. CONSEJERO: CAMPS LLUCIA CARMEN. Nombramientos. CONSEJERO: VERGES CAMPS ELISABET. Datosregistrales. T 31397 , F 146, S 8, H B 39332, I/A 29 (14.10.10).