Actos BORME de Bmind Sales Maker Company Sl
05 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 42603 , F 54, S 8, H M 609724, I/A 18 (28.09.23).
24 de Enero de 2023Cambio de domicilio social. C/ DE MARIA TUBAU 9 - PLANTA 3-B. BILMA CENTRO EMP (MADRID). Datos registrales. T 42603 ,F 54, S 8, H M 609724, I/A 17 (17.01.23).
14 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CA脩ETE ABENGOCHEA RAMON ANGEL;BARAGA脩O CAVERO JOSE CELSO;SALVANI ELISABETTA.Datos registrales. T 42603 , F 53, S 8, H M 609724, I/A 16 ( 5.12.22).
18 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 42603 , F 53, S 8, H M 609724, I/A 15 (11.11.22).
29 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: ALONSO ALDAMA ALBERTO. Datos registrales. T 42603 , F 52, S 8, H M 609724, I/A 14 (22.06.22).
29 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: TORMES GRANADOS ELISA. Datos registrales. T 42603 , F 52, S 8, H M 609724, I/A 13 (22.12.21).
12 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO ALDAMA ALBERTO;GARCIA PINA HUMBERTO MANUEL;GASCON CONDE CRISTINA;SANZPEREZ RUBEN. Nombramientos. Apoderado: GALVAN GARRIDO GONZALO;FERRANDIZ MORENO LUIS. Datos registrales. T33881 , F 225, S 8, H M 609724, I/A 12 ( 3.11.21).
27 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GALVAN GARRIDO GONZALO. Con.Delegado: GALVAN GARRIDO GONZALO. Presidente:GALVAN GARRIDO GONZALO. Consejero: ALONSO ALDAMA ALBERTO;GARCIA PINA HUMBERTO MANUEL;SAENZ DEBURUAGA PEREZ-ACHA GABRIEL;FERRANDIZ MORENO LUIS. SecreNoConsj: DIEZ RODRIGUEZ SANTIAGO. VsecrNoConsj:REDON REVUELTA BEGO脩A. Nombramientos. Adm. Unico: SEROLE INVERSIONES SL. Representan: FERNANDEZESCRIBANO FERNANDEZ JOAQUIN IGNACIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 33881 , F 224, S 8, H M 609724, I/A 10 (20.10.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERRANDIZ MORENO LUIS;GALVAN GARRIDO GONZALO;PEREZ SANZ RUBEN. Datos registrales.T 33881 , F 224, S 8, H M 609724, I/A 11 (20.10.21).
06 de Abril de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SEROLE INVERSIONES SL. Datos registrales. T 33881 , F 224, S 8, H M 609724,I/A 9 (26.03.21).
11 de Marzo de 2021Nombramientos. Consejero: SAENZ DE BURUAGA PEREZ-ACHA GABRIEL;FERRANDIZ MORENO LUIS. Modificacionesestatutarias. SUPRIMIDO EL ARTICULO 5BIS Y MODIFICADOS LOS ARTICULOS 5, 7 Y 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Datos registrales. T 33881 , F 222, S 8, H M 609724, I/A 8 ( 4.03.21).
28 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PHINEAS PLACE CONSULTING SL;BALLESTER RODRIGO JOSE CARLOS. Representan: RUBIOALVAREZ JOSE IGNACIO. Nombramientos. Consejero: ALONSO ALDAMA ALBERTO;GARCIA PINA HUMBERTO MANUEL.Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.860,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.140,00 Euros. Otros conceptos: Renumeraci贸nde las participaciones sociales como consecuencia de la amortizaci贸n de las participaciones sociales. Datos registrales. T 33881 , F218, S 8, H M 609724, I/A 7 (18.12.20).
16 de Diciembre de 2020Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 33881 , F 218, S 8, H M 609724, I/A 6 ( 9.12.20).
05 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GASCON CONDE CRISTINA;SANZ PEREZ RUBEN. Datos registrales. T 33881 , F 218, S 8, H M609724, I/A 5 (29.07.20).
29 de Julio de 2020Ampliacion del objeto social. sdffga. Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 42 3 (MADRID). Datosregistrales. T 33881 , F 218, S 8, H M 609724, I/A 4 (22.07.20).
18 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO ALDAMA ALBERTO;GARCIA PINA HUMBERTO MANUEL. Datos registrales. T 33881 , F 26,S 8, H M 609724, I/A 3 (11.12.18).
15 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALVAN GARRIDO GONZALO. Nombramientos. Consejero: GALVAN GARRIDOGONZALO;PHINEAS PLACE CONSULTING SL;BALLESTER RODRIGO JOSE CARLOSCon.Delegado: GALVAN GARRIDOGONZALO. Presidente: GALVAN GARRIDO GONZALO. VsecrNoConsj: REDON REVUELTA BEGO脩A. SecreNoConsj: DIEZRODRIGUEZ SANTIAGO. Representan: RUBIO ALVAREZ JOSE IGNACIO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 15.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Capital.-. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 5, 6, 7,8, 9, 10, 11. Art铆culo de los estatutos: 4. Capital.-. CREACION DEL ARTICULO 5潞-BIS. APROBACION DELNUEVO TEXTO INTEGRO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. PLAZA DE CARLOS TRIAS BELTRAN 7 - EDIFICIOSOLLUB (MADRID). Datos registrales. T 33881 , F 20, S 8, H M 609724, I/A 2 ( 7.12.15).
30 de Septiembre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.09.15. Objeto social: AGENCIA DE PUBLICIDAD. CNAE 7311. Domicilio: C/ ISAACALBENIZ 67 2潞 A (MAJADAHONDA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: GALVAN GARRIDO GONZALO. Datosregistrales. T 33881 , F 19, S 8, H M 609724, I/A 1 (21.09.15).