Buscador CIF Logo

Actos BORME Bmw Madrid Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bmw Madrid Sl

Actos BORME Bmw Madrid Sl - B83901561

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Bmw Madrid Sl con CIF B83901561

馃敊 Perfil de Bmw Madrid Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Bmw Madrid Sl

18 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Liquidador M: ESSIG TOBIAS AMBROS;TERROBA FERNANDEZ MANUEL;HERNAIZ GOMEZ DEGANO LUISMARIA;ALSINA ARIZAGA ANA;MENDEZ AMBROSIO MARIA ISABEL. Secretario: HERNAIZ GOMEZ DEGANO LUIS MARIA.Consejero: HERNAIZ GOMEZ DEGANO LUIS MARIA;TERROBA FERNANDEZ MANUEL. Presidente: TERROBA FERNANDEZMANUEL. Consejero: ESSIG TOBIAS AMBROS. Nombramientos. Liquidador M: ESSIG TOBIAS AMBROS;TERROBA FERNANDEZMANUEL;HERNAIZ GOMEZ DEGANO LUIS MARIA;ALSINA ARIZAGA ANA;MENDEZ AMBROSIO MARIA ISABEL. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 36958 , F 184, S 8, H M 340373, I/A 32 (11.01.23).

27 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JORGE PETISCO CESAR;OCA脩A CABEZAS MIGUEL;MORENO GARCIA MORALES JOSECARLOS. Apoderado: CONEJO RABANAL ANA MARIA. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MORATA MARIA-YOLANDA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: ALSINA ARIZAGA ANA;GUTIERREZ MU脩OZ MARIO. Datos registrales. T 36958 , F 182, S 8, H M 340373, I/A 31(20.10.22).

26 de Septiembre de 2022
Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS 118 (MADRID). Datos registrales. T 36958 , F 182, S 8, H M 340373, I/A 30(19.09.22).

20 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LUJAN MAESO RAMON;MARTIN AZORES MIGUEL ANGEL;GAMARRA HIDALGO MANUEL JOSE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: CONGOSTO FERNANDEZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 36958 , F 181, S 8, H M 340373,I/A 29 (13.06.22).

17 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: LETZGUS VOLKER. Revocaciones. Apo.Man.Soli: LETZGUS VOLKER. Nombramientos.Consejero: ESSIG TOBIAS AMBROS. Apoderado: ESSIG TOBIAS AMBROS. Datos registrales. T 36958 , F 179, S 8, H M 340373,I/A 28 (10.09.20).

14 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36958 , F 178, S 8, H M 340373,I/A 27 ( 7.11.19).

19 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SEEMANN GUNTHER. Presidente: SEEMANN GUNTHER. Revocaciones. Apo.Man.Soli:SEEMANN GUNTHER. Nombramientos. Consejero: TERROBA FERNANDEZ MANUEL. Presidente: TERROBA FERNANDEZMANUEL. Apoderado: TERROBA FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 36958 , F 177, S 8, H M 340373, I/A 26 (13.06.19).

04 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BETZ JOHANN. Revocaciones. Apoderado: BETZ JOHANN. Nombramientos. Consejero:LETZGUS VOLKER. Apo.Man.Soli: LETZGUS VOLKER. Datos registrales. T 36958 , F 175, S 8, H M 340373, I/A 25 (21.06.18).

28 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MORATA MARIA-YOLANDA. Datos registrales. T 28261 , F 205, S 8, H M 340373, I/A24 (21.05.18).

27 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: CONEJO RABANAL ANA MARIA. Datos registrales. T 28261 , F 204, S 8, H M 340373, I/A 23(20.02.17).

25 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28261 , F 203, S 8, H M 340373, I/A 22 (14.10.16).

07 de Junio de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VON KUENHEIM HENDRIK. Apo.Manc.: LUJAN MAESO RAMON;MU脩OZ GOMEZ DAVID;RAMIREZDORADO JOSE RAMON. Apoderado: MARTINEZ GONZALEZ JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAMARRA HIDALGOMANUEL JOSE. Datos registrales. T 28261 , F 202, S 8, H M 340373, I/A 21 (27.05.16).

02 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28261 , F 202, S 8, H M 340373, I/A 20 (22.09.15).

13 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AYALA ENCINAS MARGARITA. Datos registrales. T 28261 , F 200, S 8, H M 340373, I/A 19 (5.08.15).

12 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: BAU FERNANDEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 28261 , F 199, S 8, H M 340373, I/A 18 ( 5.02.15).

02 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ GONZALEZ JOAQUIN. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GONZALEZJOAQUIN. Nombramientos. Consejero: HERNAIZ GOMEZ-DEGANO LUIS MARIA. Apo.Man.Soli: HERNAIZ GOMEZ-DEGANOLUIS MARIA. Datos registrales. T 28261 , F 198, S 8, H M 340373, I/A 17 (26.08.14).

24 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: VOLKMER GERNOT. Presidente: VOLKMER GERNOT. Revocaciones. Apoderado: VOLKMERGERNOT. Nombramientos. Consejero: SEEMANN GUNTHER. Presidente: SEEMANN GUNTHER. Apo.Man.Soli: SEEMANNGUNTHER. Datos registrales. T 28261 , F 196, S 8, H M 340373, I/A 16 (16.10.13).

24 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN AZORES MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 28261 , F 195, S 8, H M 340373, I/A 15 (4.09.13).

15 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAUMGARTNER MARKUS PETER. Revocaciones. Apo.Man.Soli: BAUMGARTNERMARKUS;CORONADO GONZALEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: BETZ JOHANN. Apoderado: BETZ JOHANN. Datosregistrales. T 28261 , F 193, S 8, H M 340373, I/A 14 ( 6.02.13).

09 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLAVERDE EDUARDO. Presidente: VILLAVERDE EDUARDO. Nombramientos. Consejero:VOLKMER GERNOT. Presidente: VOLKMER GERNOT. Datos registrales. T 28261 , F 193, S 8, H M 340373, I/A 13 (28.12.11).

20 de Septiembre de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLAVERDE EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: VOLKMER GERNOT. Datos registrales. T28261 , F 191, S 8, H M 340373, I/A 12 ( 8.09.11).

01 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: RICHMANN STEFAN. Revocaciones. Apoderado: LUJAN MAESO RAMON;MU脩OZ GOMEZDAVID;RAMIREZ DORADO JOSE RAMON;MORENO GARCIA MORALES JOSE CARLOS;CONGOSTO FERNANDEZ JUANIGNACIO;JORGE PETISCO CESAR;MARTINEZ GONZALEZ JOAQUIN;VILLAVERDE EDUARDO;RICHMANN STEFAN.Apo.Man.Soli: OCA脩A CABEZAS MIGUEL. Apoderado: CONGOSTO FERNANDEZ JUAN IGNACIO. Nombramientos. Consejero:BAUMGARTNER MARKUS PETER. Apo.Man.Soli: VILLAVERDE EDUARDO;BAUMGARTNER MARKUS;MARTINEZ GONZALEZJOAQUIN;JORGE PETISCO CESAR;RAMIREZ DORADO JOSE RAMON;OCA脩A CABEZAS MIGUEL;LUJAN MAESORAMON;CORONADO GONZALEZ ALBERTO;MORENO GARCIA MORALES JOSE CARLOS. Apo.Sol.: HERNAIZ GOMEZ-DEGANOLUIS MARIA;BASSOLS HEVIA AZA MARTIN. Apo.Man.Soli: MENDEZ AMBROSIO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 19404 , F98, S 8, H M 340373, I/A 11 (19.01.11).

29 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: URBISTONDO GAYTAN DE AYALA IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: HERNAIZGOMEZ-DEGANO LUIS MARIA. Datos registrales. T 19404 , F 98, S 8, H M 340373, I/A 10 (17.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n