Actos BORME de Bodaclick Sa
07 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ ANDRES CONCEPCION. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 127/2014.FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/04/2016. Auto de conclusi贸n del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 11JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARMEN GONZALEZ SUAREZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal127/2014. Fecha de resoluci贸n 10/04/2014. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE MADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 12/04/2016, NIF/CIF B86416088.CONCURLEX ABOGADOS SLP. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 127/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n12/04/2016. Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEMADRID. Juez: CARMEN GONZALEZ SUAREZ. Extinci贸n. Datos registrales. T 27511 , F 209, S 8, H M 253766, I/A 57 (31.07.18).
22 de Octubre de 2014Otros conceptos: CONVERSION DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 127/2014 DE ABREVIADO, EN ORDINARIO. Datosregistrales. T 27511 , F 208, S 8, H M 253766, I/A B (15.10.14).
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 127/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 10/04/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO. Datosregistrales. T 27511 , F 208, S 8, H M 253766, I/A 55 (15.10.14).
20 de Octubre de 2014Nombramientos. Representan: GONZALEZ ANDRES CONCEPCION. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 127/2014.FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 10/04/2014. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE MADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO. Resoluciones: Las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre elpatrimonio del deudor quedan intervenidas por la administraci贸n concursal.- Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal127/2014. Fecha de resoluci贸n 10/04/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEMADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 10/04/2014, NIF/CIF B86416088. CONCURLEXABOGADOS SLP. Datos registrales. T 27511 , F 207, S 8, H M 253766, I/A A (13.10.14).
19 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. ComiSinObli: ALLUE MERCHAN RICARDO. Nombramientos. ComiSinObli: OLARRA ZORROZUA JUANCARLOS. Datos registrales. T 27511 , F 207, S 8, H M 253766, I/A 54 ( 8.08.14).
07 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: GARCIA RODRIGUEZ JUAN;VEGA DE SEOANE PEREZ DE VILLAMIL IGNACIO. Datos registrales.T 27511 , F 206, S 8, H M 253766, I/A 52 (26.06.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: ALLUE MERCHAN RICARDO. Apo.Sol.: ALLUE MERCHAN RICARDO. Datos registrales. T 27511 , F207, S 8, H M 253766, I/A 53 (26.06.14).
25 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO. Presidente: HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO. Datosregistrales. T 27511 , F 206, S 8, H M 253766, I/A 51 (17.02.14).
29 de Enero de 2014Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 27511 , F 205, S 8, H M 253766, I/A 50 (21.01.14).
24 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ ALLES JOSE MANUEL. Apo.Manc.: SANCHEZ ALLES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GARCIA-FONTECHA PEDREGAL PATRICIA. Nombramientos. Apoderado: DE HARO YAGUE DANIEL. Datos registrales. T 27511 , F 205,S 8, H M 253766, I/A 49 (17.12.13).
12 de Diciembre de 2013Nombramientos. ComiSinObli: ALLUE MERCHAN RICARDO. Emisi贸n de obligaciones. Comisario: ALLUE MERCHAN RICARDO.Importe de la emisi贸n: 4.000.000,00 Euros. 18.11.13. Datos registrales. T 27511 , F 200, S 8, H M 253766, I/A 48 ( 3.12.13).
02 de Septiembre de 2013Cambio de domicilio social. C/ RUFINO GONZALEZ 40 - 3& PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 27511 , F 200, S 8, H M253766, I/A 47 (22.08.13).
12 de Agosto de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: GALBETE DE LA SERNA PALOMA. Apoderado: HERNANDEZ DE LOS SANTOS ORTIZ LUIS;MARTINMARTINEZ VERONICA;HERNANDEZ DE LOS SANTOS ORTIZ LUIS. Apo.Sol.: LOBO SANZ MONICA MARIA. Datos registrales. T27511 , F 199, S 8, H M 253766, I/A 46 ( 5.08.13).
28 de Mayo de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: HAMPARZOUMIAN ARANGO GONZALO. Datos registrales. T 27511 , F 199, S 8, H M 253766, I/A45 (20.05.13).
20 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: PEREZ DE VAL SHERIFF LUIS. Nombramientos. Cons.Del.Sol: VEGA DE SEOANE PEREZ DEVILLAAMIL IGNACIO. Datos registrales. T 27511 , F 198, S 8, H M 253766, I/A 44 (12.03.13).
11 de Marzo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: VEGA DE SOANE PEREZ DE VILLAMIL I脩IGO;ROVES SUAREZ FRANCISCO. Datos registrales.T 27511 , F 198, S 8, H M 253766, I/A 43 ( 1.03.13).
23 de Enero de 2013Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 105 (MADRID). Datos registrales. T 27511 , F 198, S 8, H M 253766, I/A 42(15.01.13).
11 de Diciembre de 2012Modificaciones estatutarias. se modifica el "ARTICULO 19.- CONVOCATORIA" de los Estatutos.. P谩gina web de la sociedad.Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.bodaclick.com. Datos registrales. T 27511 , F 197, S 8, H M 253766, I/A 41 (28.11.12).
08 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PARRA VICENTE. Datos registrales. T 27511 , F 195, S 8, H M 253766, I/A 39 (26.10.12).
Revocaciones. Apoderado: GALBETE DE LA SERNA PALOMA. Apo.Man.Soli: GALBETE DE LA SERNA PALOMA. Apoderado:GALBETE DE LA SERNA PALOMA. Apo.Man.Soli: LOBO SANZ MONICA MARIA. Apoderado: GALBETE DE LA SERNAPALOMA;LOBO SANZ MONICA MARIA;LOBO SANZ MONICA MARIA;GALBETE DE LA SERNA PALOMA. Nombramientos.Apo.Sol.: SANCHEZ ALLES JOSE MANUEL;LOBO SANZ MONICA MARIA;ALLUE MERCHAN RICARDO. Apo.Manc.: ALLUEMERCHAN RICARDO;SANCHEZ ALLES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GARCIA-FONTECHA PEDREGAL PATRICIA. Datos registrales.T 27511 , F 195, S 8, H M 253766, I/A 40 (29.10.12).
19 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUE CAMPS JOSEP. Presidente: PIQUE CAMPS JOSEP. Consejero: DIEZ-HOCHLEITNERRODRIGUEZ EDUARDO. Nombramientos. Presidente: HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO. Vicepresid.: ANDRADE MORENOINES ELVIRA. Datos registrales. T 27511 , F 195, S 8, H M 253766, I/A 38 ( 7.09.12).
20 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VEGA DE SEOANE PEREZ DE VILLAAMIL IGNACIO. Datos registrales. T 27511 , F 195, S 8, HM 253766, I/A 37 ( 8.06.12).
12 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ PARRA VICENTE. Datos registrales. T 27511 , F 194, S 8, H M 253766, I/A 35(27.03.12).
Revocaciones. Apoderado: MARTIN MARTINEZ VERONICA. Datos registrales. T 27511 , F 194, S 8, H M 253766, I/A 36(27.03.12).
17 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: LOBO SANZ MONICA MARIA;GALBETE DE LA SERNA PALOMA. Datos registrales. T 27511 , F194, S 8, H M 253766, I/A 34 ( 3.10.11).
29 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ DE LOS SANTOS ORTIZ LUIS. Datos registrales. T 27511 , F 194, S 8, H M 253766,
12 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: GALBETE DE LA SERNA PALOMA;MARTIN MARTINEZ VERONICA;LOBO SANZ MONICAMARIA;ALLUE MERCHAN RICARDO. Datos registrales. T 27511 , F 193, S 8, H M 253766, I/A 32 ( 1.04.11).
01 de Abril de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALLUE MERCHAN RICARDO;LOBO SANZ MONICA MARIA. Datos registrales. T 27511 , F 193, S8, H M 253766, I/A 31 (21.03.11).
08 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: ALLUE MERCHAN RICARDO. Datos registrales. T 27511 , F 193, S 8, H M 253766, I/A 30(26.10.10).
11 de Octubre de 2010Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T27511 , F 192, S 8, H M 253766, I/A 29 (28.09.10).
30 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: ALLUE MERCHAN RICARDO;HERNANDEZ DE LOS SANTOS ORTIZ LUIS. Datos registrales. T27511 , F 192, S 8, H M 253766, I/A 28 (17.09.10).
07 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: PEREZ DEL VAL SHERIFF LUIS;VEGA DE SEOANE PEREZ DE VILLAMIL IGNACIO. Ampliaci贸n decapital. Suscrito: 71.944,18 Euros. Desembolsado: 71.944,18 Euros. Resultante Suscrito: 323.516,18 Euros. ResultanteDesembolsado: 323.516,18 Euros. Datos registrales. T 27511 , F 190, S 8, H M 253766, I/A 27 (28.06.10).
16 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ PARADELA ELISA. Consejero: FIGUEROLA FERRETTI GIL LUIS;VEGA DESEOANE AZPILICUETA JAIME;DIEZ HOCHLEITNER RODRIGUEZ EDUARDO. Presidente: DIEZ HOCHLEITNER RODRIGUEZEDUARDO. Consejero: MEBY INVERSIONES SL. Nombramientos. Ent.Reg.Cont: IBERCLEAR SOCIEDAD DE GESTION DE LOSSISTEMAS DE R. Consejero: PIQUE CAMPS JOSEP. Presidente: PIQUE CAMPS JOSEP. Consejero: DIEZ-HOCHLEITNERRODRIGUEZ EDUARDO;HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO;JUANTEGUI AZPILICUETA PABLO ANTONIO;ANDRADEMORENO INES ELVIRA. Reelecciones. Secretario: DUTILH ABOGADOS SLP. Representan: DUTILH CARVAJAL ISABEL.Consejero: VEGA DE SEOANE PEREZ DE VILLAMIL IGNACIO;PEREZ DE VAL SHERIFF LUIS. Cons.Del.Sol: PEREZ DE VALSHERIFF LUIS;VEGA DE SEOANE PEREZ DE VILLAAMIL IGNACIO. Otros conceptos: REDUCIDO EL VALOR NOMINAL DE LASACCIONES QUE PASA A SER DE0,02 EUROS, MODIFICANDO SU SISTEMA DE REPRESENTACION, PASANDO A SERANOTACIONES EN CUENTA, Y MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A INCLUSION DE UN NUEVOARTICULO6; Y MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 15172 , F 224, S 8, H M253766, I/A 26 ( 2.06.10).