Actos BORME de Bodegas Fuenmayor Sociedad Anonima
27 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DE MIGUEL CORDON RICARDO. Datos registrales. T 556 , F 130, S 8, H LO 5856, I/A 37(18.10.22).
18 de Abril de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.669.996,80 Euros. Resultante Suscrito: 667.998,72 Euros. Datos registrales. T 556 , F129, S 8, H LO 5856, I/A 36 (31.03.22).
17 de Diciembre de 2020Modificaciones estatutarias. Modificada la redacci贸n del art铆culo 9潞 de los estatutos sociales relativo a la junta general deaccionistas. Datos registrales. T 556 , F 129, S 8, H LO 5856, I/A 35 ( 9.12.20).
05 de Noviembre de 2019Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 5潞 de los Estatutos. Datos registrales. T 556 , F 128, S 8, H LO 5856, I/A 34(23.10.19).
Otros conceptos: Sustituci贸n de la totalidad de los t铆tulos f铆sicos existentes, que ser谩n anulados por 18 nuevos t铆tulos nominativosm煤ltiples acreditativos de la titularidad de las acciones que corresponden a da uno de los accionistas. Datos registrales. T 556 , F128, S 8, H LO 5856, I/AN. Ma (23.10.19).
16 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 556 , F 128, S 8, H LO 5856, I/A 33 (8.07.19).
01 de Septiembre de 2017Nombramientos. Consejero: CARCAMO UYARRA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 556 , F 128, S 8, H LO 5856, I/A 32(23.08.17).
17 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ACHIAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER;PIULATS SAMPERI FRANCISCO JOSE. Presidente:ACHIAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Secretario: PIULATS SAMPERI FRANCISCO JOSE. Con.Delegado: ACHIAGA LOPEZ JOSEIGNACIO. Consejero: ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: DE MIGUEL CORDON RICARDO.Presidente: TRASTOY FRANCO JOSE LUIS. Consejero: GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS;MARTINEZ HUEDA OSCAR.Vicepresid.: MARTINEZ HUEDA OSCAR. Con.Delegado: MARTINEZ HUEDA OSCAR. Datos registrales. T 556 , F 127, S 8, H LO5856, I/A 31 ( 9.11.16).
19 de Septiembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 459.338,04 Euros. Desembolsado: 459.338,04 Euros. Resultante Suscrito: 2.337.995,52 Euros.Resultante Desembolsado: 2.337.995,52 Euros. Datos registrales. T 522 , F 104, S 8, H LO 5856, I/A 30 ( 5.09.16).
12 de Agosto de 2016Revocaciones. Apoderado: HERNAIZ DE MARCOS JUDITH. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ HUEDA OSCAR. Datosregistrales. T 522 , F 104, S 8, H LO 5856, I/A 29 ( 1.08.16).
01 de Febrero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.594.336,52 Euros. Resultante Suscrito: 1.878.657,48 Euros. Datos registrales. T 522 , F104, S 8, H LO 5856, I/A 28 (22.01.16).
16 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ACHIAGA LOPEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 522 , F 104, S 8, H LO 5856, I/A 27 ( 7.01.15).
07 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ACHIAGA LOPEZ MARIA JOSE;ACHIAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER;ACHIAGA LOPEZ JOSEIGNACIO;BARRIO HEREDIA ISABEL. Presidente: BARRIO HEREDIA ISABEL. Consejero: MONEDERO VEGA RAFAEL. Vicepresid.:MONEDERO VEGA RAFAEL. Con.Delegado: ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO. SecreNoConsj: DE MIGUEL CORDON RICARDO.Nombramientos. Consejero: ACHIAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: ACHIAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.Consejero: PIULATS SAMPERI FRANCISCO JOSE. Secretario: PIULATS SAMPERI FRANCISCO JOSE. Consejero: ACHIAGALOPEZ JOSE IGNACIO;ACHIAGA LOPEZ MARIA JOSE. Con.Delegado: ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO. Modificacionesestatutarias. ARTICULO 10.- La sociedad, ser谩 administrada y regida por el Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 522 , F104, S 8, H LO 5856, I/A 26 (30.07.14).
24 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ-AMOR GARCIA FERNADO;BERGARECHE BUSQUET JORGE. Datos registrales. T 522 , F103, S 8, H LO 5856, I/A 25 (16.12.13).
03 de Abril de 2013Otros conceptos: Con fecha 25/6/2012, se han emitido, impreso y entregado a los accionistas 14 t铆tulos m煤ltiples, N潞 1 a 14,inclusive, que comprenden: 1: 96.129 acciones, 2: 64.086, 3: 64.086, 4 :202.075, 5: 64.086, 6: 64.086, 7: 75.560, 8: 117.796, 9: 47.303,10: 79.345, 11: 494.394, 12:19.820 y 12: 60.232. Datos registrales. T 522 , F 102, S 8, H LO 5856, I/ANota (22.03.13).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.058.397,60 Euros. Datos registrales. T 522 , F 103, S 8, H LO 5856, I/A 24(22.03.13).
04 de Octubre de 2012Modificaciones estatutarias. Modificada la redacci贸n del art铆culo 9潞 de los estatutos sociales relativo a la junta general deaccionistas. Datos registrales. T 522 , F 102, S 8, H LO 5856, I/A 23 (25.09.12).
09 de Enero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 63.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.472.994,00 Euros. Datos registrales. T 522 , F102, S 8, H LO 5856, I/A 22 (28.12.11).
03 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.511.997,00 Euros. Desembolsado: 453.599,40 Euros. Resultante Suscrito: 4.535.994,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.461.846,40 Euros. Datos registrales. T 522 , F 101, S 8, H LO 5856, I/A 21 (22.04.10).
07 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: BARRIO HEREDIA ISABEL. Pres.Com.Ej.: BARRIO HEREDIA ISABEL. Miem.Com.Ej.: DEMIGUEL CORDON RICARDO;ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO;CUTILLAS CORDON CARLOS;GARCIA GONZALEZ JOSELUIS;TORREALBA ELIAS JOSE ANTONIO. Sec.Com.Ej.: DE MIGUEL CORDON RICARDO. Consejero: BERGARECHE BUSQUETJORGE;VICENTE MATIAS ALFREDO;ACHIAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER;APILEMA SOCIEDAD LIMITADA;BARRIO HEREDIAISABEL. Presidente: BARRIO HEREDIA ISABEL. Consejero: DE MIGUEL CORDON RICARDO. Secretario: DE MIGUEL CORDONRICARDO. Consejero: CUTILLAS CORDON JORGE;LOPEZ-AMOR GARCIA FERNADO;GARCIA GONZALEZ JOSELUIS;MONEDERO VEGA RAFAEL;TORREALBA ELIAS JOSE ANTONIO;CUTILLAS CORDON CARLOS;AGUIRRE NAVAJASJAVIER;ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO. Con.Delegado: ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO. Consejero: GARCIA RAMIREZ JUANCARLOS. Miem.Com.Ej.: BARRIO HEREDIA ISABEL;DE MIGUEL CORDON RICARDO;ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO;CUTILLASCORDON CARLOS JAVIER;TORREALBA ELIAS JOSE ANTONIO;GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS.Pres.Com.Ej.: BARRIOHEREDIA ISABEL. Sec.Com.Ej.: DE MIGUEL CORDON RICARDO. Con.Delegado: ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO.Nombramientos. Consejero: ACHIAGA LOPEZ MARIA JOSE;ACHIAGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER;ACHIAGA LOPEZ JOSEIGNACIO;LOPEZ-AMOR GARCIA FERNADO;BERGARECHE BUSQUET JORGE;BARRIO HEREDIA MARIA ISABEL. Presidente:BARRIO HEREDIA MARIA ISABEL. Consejero: MONEDERO VEGA RAFAEL. Vicepresid.: MONEDERO VEGA RAFAEL.SecreNoConsj: DE MIGUEL CORDON RICARDO. Con.Delegado: ACHIAGA LOPEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 522 , F100, S 8, H LO 5856, I/A 20 (25.09.09).
03 de Septiembre de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 236.249,25 Euros. Datos registrales. T 522 , F 100, S 8, H LO 5856, I/A 19(25.08.09).