Actos BORME de Bodegas Martue La Guardia Sa
13 de Noviembre de 2015Fe de erratas: Por sentencia firme dictada el 07/01/2015 por el Juzgado de 1& Instancia e Instrucci贸n n潞 1 de Toledo, se declar贸 lanulidad de la totalidad de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administraci贸n de la Sociedad demandada, habidos el 21 de juniode 2014, cancel谩ndose la inscripci贸n 21&. Datos registrales. T 1592 , F 148, S 8, H TO 16136, I/A 24 (29.10.15).
05 de Noviembre de 2015Fe de erratas: Por sentencia firme dictada el 07/01/2015 por el Juzgado de 1& Instancia e Instrucci贸n n潞 1 de Toledo, se declar贸 lanulidad de la totalidad de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administraci贸n de la Sociedad demandada, habidos el 21 de juniode 2014, cancel谩ndose la inscripci贸n 20&. Por. Datos registrales. T 1592 , F 148, S 8, H TO 16136, I/A 24 (29.10.15).
14 de Agosto de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 206/2015. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 3/07/2015. Auto de declaraci贸n de
15 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CUTILLAS CORDON JORGE ARTURO;CUTILLAS CORDON CARLOS JAVIER;ALI脩O DIAZ-TERANFRANCISCO-JAVIER;FERNANDEZ-VEGA FEIJOO ARUCA;ARAGON ALVAREZ EMILIO TOMAS. Presidente: CUTILLAS CORDONJORGE ARTURO. Secretario: CUTILLAS CORDON CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 1592 , F 147, S 8, H TO 16136, I/A 23 (5.01.15).
02 de Octubre de 2014Fe de erratas: RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 12&. Datos registrales. T 1592 , F 147, S 8, H TO 16136, I/A 22 (25.09.14).
14 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GONZALEZ BORREGO FAUSTO. Presidente: GONZALEZ BORREGO FAUSTO.Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ BORREGO FAUSTO;GONZALEZ BORREGO FAUSTO. Nombramientos. Presidente:CUTILLAS CORDON JORGE ARTURO. Apoderado: CUTILLAS CORDON JORGE ARTURO. Datos registrales. T 1558 , F 78, S 8,H TO 16136, I/A 20 ( 7.08.14).
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ABAD JULIAN-JOSE;RODRIGUEZ ABAD JULIAN-JOSE. Apoderado: RODRIGUEZ ABADJULIAN-JOSE. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-VEGA FEIJOO ARUCA. Datos registrales. T 1592 , F 146, S 8, H TO16136, I/A 21 ( 7.08.14).
15 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 726.200,00 Euros. Desembolsado: 726.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.963.900,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.963.900,00 Euros. Datos registrales. T 1558 , F 77, S 8, H TO 16136, I/A 19 (30.12.13).
15 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA-CORDERO CELIS ANGEL. Datos registrales. T 1558 , F 77, S 8, H TO 16136, I/A 18 (7.11.13).
15 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ABAD JULIAN-JOSE. Datos registrales. T 1412 , F 46, S 8, H TO 16136, I/A 17 (8.01.13).
24 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ BORREGO MANUEL. Nombramientos. Consejero: ALI脩O DIAZ-TERAN FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 1412 , F 46, S 8, H TO 16136, I/A 16 (14.08.12).
03 de Noviembre de 2011Reelecciones. Consejero: GONZALEZ BORREGO FAUSTO;GONZALEZ BORREGO MANUEL;RODRIGUEZ ABADMARTA;RODRIGUEZ ABAD JULIAN-JOSE. Secretario: CUTILLAS CORDON CARLOS JAVIER. Consejero: CUTILLAS CORDONJORGE ARTURO;ARAGON ALVAREZ EMILIO TOMAS;FERNANDEZ-VEGA FEIJOO ARUCA;GARCIA-CORDERO CELIS ANGEL.
13 de Mayo de 2010Nombramientos. Con.Delegado: GONZALEZ BORREGO FAUSTO. Datos registrales. T 1412 , F 46, S 8, H TO 16136, I/A 14 (3.05.10).