Buscador CIF Logo

Actos BORME Bodegas Raiz Y Quesos Paramo De Guzman Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bodegas Raiz Y Quesos Paramo De Guzman Sl

Actos BORME Bodegas Raiz Y Quesos Paramo De Guzman Sl - B09262098

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Bodegas Raiz Y Quesos Paramo De Guzman Sl con CIF B09262098

馃敊 Perfil de Bodegas Raiz Y Quesos Paramo De Guzman Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Bodegas Raiz Y Quesos Paramo De Guzman Sl

27 de Abril de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DERECHOS DEL SESENTA SL. Datos registrales. T 779, L 570, F 30, S 8, H BU2334, I/A 47 (21.04.23).

02 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS SANCHIS CINTIA;ALONSO SAEZ ROCIO;SABOVA BILYUKOVA STEFKA. Datos registrales.T 779, L 570, F 30, S 8, H BU 2334, I/A 46 (27.05.21).

04 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS. Apoderado: GONZALEZ CANTON MARIA MILAGROS. Apo.Man.Soli:HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS;FERNANDEZ DE VALDERRAMA ALTABLE JAVIER;SABOVA BILYUKOVA STEFKA;LUCASTEJEDA ANASTASIO;HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS;LUCAS TEJEDA ANASTASIO;SABOVA BILYUKOVASTEFKA;FERNANDEZ DE VALDERRAMA ALTABLE JAVIER. Apoderado: MERINO ARAGONESES MARIA JESUS;MARTIN NIETOLAURA. Apo.Sol.: ALONSO SAEZ ROCIO. Apoderado: LUCAS TEJEDA ANASTASIO. Datos registrales. T 779, L 570, F 30, S 8, HBU 2334, I/A 45 (29.01.21).

21 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS SANCHIS CINTIA;ALONSO SAEZ ROCIO;SABOVA BILYUKOVA STEFKA. Datosregistrales. T 728, L 519, F 92, S 8, H BU 2334, I/A 44 (15.01.21).

16 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL;SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA;HERREZUELO CABEZAJOSE LUIS;FIGUEROA VILLOTA IGNACIO JOAQUIN;MARTINEZ DE AZCOITIA MIGUELEZ MARIA DE LA PALOMA;FERNANDEZDE VALDERRAMA ALTABLE JAVIER;SANTOCILDES CASTA脩ON ANTONIO;TAULET FERRANDO EDUARDO JOSE. Presidente:SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: SANTOS ALONSO MIGUEL ANGEL. Secretario: HERREZUELO CABEZA JOSELUIS. Nombramientos. Consejero: INVERSIONES 2012 BUSINESS PROJECTS SL;INVERSIONES 2012 DESARROLLO DENEGOCIOS SLSecretario: SANTOS MARTINEZ DE AZCOITIA CAYETANA. Presidente: INVERSIONES 2012 BUSINESS PROJECTSSL. Cons.Del.Sol: INVERSIONES 2012 BUSINESS PROJECTS SL. Vicepresid.: INVERSIONES 2012 DESARROLLO DE NEGOCIOSSL. Cons.Del.Sol: INVERSIONES 2012 DESARROLLO DE NEGOCIOS SL. Datos registrales. T 728, L 519, F 91, S 8, H BU 2334,I/A 43 ( 6.11.20).

29 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: JULVEZ PERIS-MARTIN JOSE LUIS;CARNERO FERNANDEZ VICENTE. Nombramientos.Consejero: SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA;SANTOCILDES CASTA脩ON ANTONIO;TAULET FERRANDO EDUARDO JOSE.Datos registrales. T 728, L 519, F 91, S 8, H BU 2334, I/A 42 (23.01.19).

25 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: MERINO ARAGONESES MARIA JESUS. Datos registrales. T 703, L 494, F 146, S 8, H BU 2334, I/A39 (19.04.17).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN NIETO LAURA. Datos registrales. T 703, L 494, F 147, S 8, H BU 2334, I/A 40 (19.04.17).

31 de Octubre de 2016
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 703, L 494, F 146, S 8, H BU 2334, I/A 38 (25.10.16).

13 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS;LUCAS TEJEDA ANASTASIO;SABOVA BILYUKOVASTEFKA;FERNANDEZ DE VALDERRAMA ALTABLE JAVIER. Datos registrales. T 703, L 494, F 144, S 8, H BU 2334, I/A 37 (5.10.16).

24 de Agosto de 2016
Revocaciones. Apoderado: COB BERDON MARIA LORETO. Datos registrales. T 703, L 494, F 143, S 8, H BU 2334, I/A 35(17.08.16).

Nombramientos. Consejero: SANTOS MARTINEZ DE AZCOITIA CAYETANA. Cons.Del.Sol: SANTOS MARTINEZ DE AZCOITIACAYETANA. Datos registrales. T 703, L 494, F 144, S 8, H BU 2334, I/A 36 (17.08.16).

03 de Agosto de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO HERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 703, L 494, F 143, S 8, H BU 2334, I/A 34(28.07.16).

08 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS;FERNANDEZ DE VALDERRAMA ALTABLE JAVIER;SABOVABILYUKOVA STEFKA;LUCAS TEJEDA ANASTASIO. Datos registrales. T 682, L 473, F 38, S 8, H BU 2334, I/A 33 ( 2.03.16).

10 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA;JURADO GRAS MANUEL. Cons.Del.Sol: SECO HIJOSAMIGUEL BAUTISTA. Vicepresid.: SECO HIJOSA MIGUEL BAUTISTA. Datos registrales. T 682, L 473, F 38, S 8, H BU 2334, I/A 32 (4.02.16).

23 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Consejero: JULVEZ PERIS-MARTIN JOSE LUIS. Datos registrales. T 682, L 473, F 37, S 8, H BU 2334, I/A 31(17.11.15).

07 de Octubre de 2014
Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ DE VALDERRAMA ALTABLE JAVIER;JURADO GRAS MANUEL;MARTINEZ DEAZCOITIA MIGUELEZ MARIA DE LA PALOMA. Datos registrales. T 682, L 473, F 37, S 8, H BU 2334, I/A 30 (30.09.14).

27 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERREZUELO CABEZA JOSE LUIS;DE VALDERRAMA ALTABLE JAVIER FERNANDEZ;SABOVABILYUKOVA STEFKA. Datos registrales. T 626, L 417, F 93, S 8, H BU 2334, I/A 29 (20.08.14).

25 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: LUCAS TEJEDA ANASTASIO. Datos registrales. T 626, L 417, F 92, S 8, H BU 2334, I/A 28(18.06.14).

15 de Enero de 2014
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 626, L 417, F 92, S 8, H BU 2334, I/A 27 ( 8.01.14).

02 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CANTON MARIA MILAGROS. Datos registrales. T 626, L 417, F 91, S 8, H BU 2334, I/A26 (23.10.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n