Actos BORME de Bodegas Valdubon Sl
21 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: ALADRO PRIETO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 799, L 590, F 52, S 8, H BU 5572, I/A 31(15.09.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARNE MASLLORENS SILVIA;FERRER MIRANDA PEDRO;LAFOURCADE FABIEN. Apo.Sol.: DELRIO OSCAR;ALADRO PRIETO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 799, L 590, F 52, S 8, H BU 5572, I/A 32 (15.09.22).
11 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: CARNE MASLLORENS SILVIA. Datos registrales. T 769, L 560, F 47, S 8, H BU 5572, I/A 28 (5.08.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL RIO MARTINEZ OSCAR. Datos registrales. T 769, L 560, F 50, S 8, H BU 5572, I/A 29 (5.08.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALADRO PRIETO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 799, L 590, F 50, S 8, H BU 5572, I/A30 ( 5.08.22).
02 de Abril de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: ALADRO PRIETO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 769, L 560, F 47, S 8, H BU 5572, I/A 27(27.03.20).
17 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARNE MASLLORENS SILVIA;FERRER MIRANDA PEDRO;LAFOURCADE FABIEN. Apo.Sol.: DELRIO OSCAR;ALADRO PRIETO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 749, L 540, F 21, S 8, H BU 5572, I/A 26 (11.02.20).
08 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: ROCA COMELLA JUAN;ABEL LLUCH JOSE LUIS. Apo.Manc.: FERRER NOGUER PEDRO. Datosregistrales. T 749, L 540, F 21, S 8, H BU 5572, I/A 25 ( 2.07.19).
02 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ LOMBARTE ANSELM. Datos registrales. T 749, L 540, F 21, S 8, H BU 5572, I/A 24(25.06.19).
13 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: ALADRO PRIETO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 749, L 540, F 21, S 8, H BU 5572, I/A23 ( 7.03.19).
10 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRER NOGUER JOSE MARIA. Presidente: FERRER NOGUER JOSE MARIA. Cons.Del.Sol:FERRER NOGUER JOSE MARIA. Secretario: AUBAREDA GIMENEZ FRANCISCO DE ASIS JAVIER. Consejero: AUBAREDAGIMENEZ FRANCISCO DE ASIS JAVIER;HEREDIA FIGUEROLA ADOLFO. Cons.Del.Sol: AUBAREDA GIMENEZ FRANCISCO DEASIS JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: FERRER NOGUER PEDRO. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre deEjercicio: 31/12. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 749, L 540, F 20, S 8, H BU 5572, I/A 21 ( 3.01.19).
Revocaciones. Apoderado: HEVIA FERRER ENRIQUE;HEREDIA FIGUEROLA ADOLFO;OLIVELLA GENE JUAN ANTON. Datosregistrales. T 749, L 540, F 21, S 8, H BU 5572, I/A 22 ( 3.01.19).
21 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: FERRER NOGUER PEDRO;SANCHEZ LOMBARTE ANSELM. Datos registrales. T 418, L 209, F 178,S 8, H BU 5572, I/A 20 (14.08.18).
27 de Septiembre de 2016Modificaciones estatutarias. 13. Adopci贸n del sistema de asistencia por medios telem谩ticos a las reuniones del Consejo. Datosregistrales. T 418, L 209, F 178, S 8, H BU 5572, I/A 19 (14.09.16).
30 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: ABEL LLUCH JOSE LUIS. Datos registrales. T 418, L 209, F 176, S 8, H BU 5572, I/A 17 (23.07.14).
Nombramientos. Apoderado: FERRER NOGUER PEDRO. Datos registrales. T 418, L 209, F 177, S 8, H BU 5572, I/A 18(23.07.14).