Buscador CIF Logo

Actos BORME Bodegas Vega Sicilia Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bodegas Vega Sicilia Sa

Actos BORME Bodegas Vega Sicilia Sa - A28132454

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Valladolid para Bodegas Vega Sicilia Sa con CIF A28132454

🔙 Perfil de Bodegas Vega Sicilia Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valladolid

Actos BORME de Bodegas Vega Sicilia Sa

10 de Agosto de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1543 , F 106, S 8, H VA 2127, I/A 78 ( 3.08.23).

03 de Enero de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDO GARCIA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1543 , F 106, S 8, H VA 2127, I/A 77(27.12.22).

09 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1543 , F 105, S 8, H VA 2127, I/A 76 ( 2.08.22).

26 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1543 , F 105, S 8, H VA 2127, I/A 75 (13.08.21).

03 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIAELVIRA;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Presidente:ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA. Secretario: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Datos registrales. T 1543 , F 105, S 8, H VA 2127, I/A 74 (26.11.20).

02 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1543 , F 105, S 8, H VA 2127, I/A 73 (26.07.19).

27 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 197, S 8, H VA 2127, I/A 72 (20.09.18).

31 de Mayo de 2018
Modificaciones estatutarias. "Artículo 7º.- TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. 1. En toda transmisión de acciones por actosintervivos a título oneroso, se observarán las siguientes normas de actuación: El accionista que se proponga transmitir sus acciones oalgunas de ellas, deberá comunicarlo por escrito, indicando su "Artículo 9º.- SOBERANIA DE LA JUNTA: La Junta General deAccionistas, debidamente convocada y constituida, decidirá por mayoría en los asuntos propios de su competencia y sus acuerdosobligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes y a los ausentes. Existirá mayoría cuando voten a favor"Artículo 7ºBIS.-PRENDA DE ACCIONES: En caso de prenda de acciones corresponderá al acreedor pignoraticio el ejercicio de los derechos políticosde las acciones dadas en prenda. . Otros conceptos: REVOCAR y dejar sin efecto, conforme a lo dispuesto en el art. 204.2 de laLSC, los acuerdos de modificación de los arts. 7º y 9º de los estatutos y la inclusión de un nuevo art 7º bis, adoptados en JuntaGeneral Extraordinaria y Universal de fecha 25 de marzo de 2013. Datos registrales. T 1369 , F 197, S 8, H VA 2127, I/A 71(24.05.18).

08 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 196, S 8, H VA 2127, I/A 70 ( 1.08.17).

04 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 196, S 8, H VA 2127, I/A 69 (28.07.16).

14 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZJUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA. Secretario: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIAELVIRA. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL. Nombramientos. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZMEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Presidente: ALVAREZMEZQUIRIZ MARTA. Secretario: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Modificaciones estatutarias. "Artículo16º.- RETRIBUCION.- El cargo de Consejero será remunerado. El sistema de remuneración consistirá en: a) una cantidad fija, y b) unaremuneración en especie consistente en la contratación de seguros médicos y abono de sus primas. El importe máximo de laremuneración anual del conjunto de. Datos registrales. T 1369 , F 196, S 8, H VA 2127, I/A 68 ( 7.07.15).

22 de Julio de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 195, S 8, H VA 2127, I/A 67 (15.07.14).

06 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 195, S 8, H VA 2127, I/A 66 ( 2.09.13).

10 de Mayo de 2013
Otros conceptos: Modificación de los Artículos 7º, 9º y 24º de los EstatutosSociales. Supresión del Artículo 25º e inclusión de unnuevoArtículo 7º Bis. Datos registrales. T 1369 , F 195, S 8, H VA 2127, I/A 65 ( 3.05.13).

30 de Julio de 2012
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, H VA 2127, I/A 64 (19.07.12).

14 de Julio de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, H VA 2127, I/A 63 ( 5.07.11).

12 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apoderado: GARCIA CAPELO MARTIN ALVARO;GARCIA MARTIN JUAN;PARES RON PEDRO;SANCHEZ SANJOSE VICENTE;ARCILA MARTIN MANUEL;FORNES PUGET GUILLERMO;RAMON ALFONSO MARTIN DE LA CONCHA;ANADONTRULLENQUE JESUS;ANADON TRULLENQUE JESUS. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, H VA 2127, I/A 62 ( 3.05.11).

04 de Abril de 2011
Otros conceptos: Conforme al Artículo 122,3 RRM se subsana el error de la certificación anterior haciendo constar que los títulosnominativos representativos de las acciones que se han emitido, impreso y entregado a los titulares han sido: Titulo nº 1 -acción nº 1- yTítulo múltiple 2 -acciones 2 a 17.500-. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, H VA 2127, I/A 61 N (24.03.11).

08 de Noviembre de 2010
Otros conceptos: Conforme al Art. 122,3 RRM se hace constar la circunstanciade haberse impreso y entregado a los titulares lostítulos nominativos representativos de las acciones de la sociedad. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, H VA 2127, I/A 61 N(27.10.10).

05 de Agosto de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, H VA 2127, I/A 61 (27.07.10).

17 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ DIEZ DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE;ALVAREZ MIZQUIRIZ MARIA JOSE.Apo.Man.Soli: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE;ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, HVA 2127, I/A 60 ( 6.05.10).

05 de Abril de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1369 , F 194, S 8, H VA 2127, I/A 59 (23.03.10).

29 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JORDANO PEREZ JUAN;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS;ESCUDERO HERREROS

15 de Marzo de 2010
Modificaciones estatutarias. Artículo 7º. Transmisibilidad de las acciones. 1. En toda transmisión de acciones por actos intervivos atítulo oneroso, se observarán las siguientes normas de actuación: El accionista que se proponga transmitir sus acciones o algunas de

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1369 , F 193, S 8, H VA 2127, I/A 57 ( 4.03.10).

04 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: CARRERO ANTIN SANTIAGO. Nombramientos. Secretario: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIAELVIRA. Presidente: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLOMANUEL. Datos registrales. T 829 , F 36, S 8, H VA 2127, I/A 55 (23.02.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JORDANO PEREZ JUAN;ALVAREZ DIEZ DAVID. Presidente: ALVAREZ DIEZ DAVID. Cons.Del.Sol:ALVAREZ DIEZ DAVID. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Nombramientos.Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUANCARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA ELVIRA;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA. Datos registrales. T 829 , F 36, S 8, H VA 2127,I/A 54 (23.02.10).

01 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Cons.Del.Sol: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL.Consejero: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZ MEZQUIRIZ ELVIRA;ALVAREZMEZQUIRIZ MARTA;DIEZ MORODO VALENTIN. Nombramientos. Consejero: JORDANO PEREZ JUAN. Reelecciones.Consejero: ALVAREZ DIEZ DAVID. Presidente: ALVAREZ DIEZ DAVID. Cons.Del.Sol: ALVAREZ DIEZ DAVID. Consejero: ALVAREZMEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Secretario: CARRERO ANTIN SANTIAGO. Datos registrales. T829 , F 34, S 8, H VA 2127, I/A 51 (21.01.10).

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZMEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MIZQUIRIZ PABLO MANUEL. Apo.Sol.: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS;ALVAREZMEZQUIRIZ EMILIO. Datos registrales. T 829 , F 34, S 8, H VA 2127, I/A 52 (21.01.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JORDANO PEREZ JUAN;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS;ESCUDERO HERREROSELEUTERIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE;ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID. Datos registrales. T 829 , F 35, S 8, H VA2127, I/A 53 (21.01.10).

30 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 829 , F 34,S 8, H VA 2127, I/A 50 (19.11.09).

05 de Febrero de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 829 , F 34, S 8, H VA 2127, I/A 49 (27.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información