Actos BORME de Boetticher Y Navarro Sl
05 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ GARCIA-LOMAS BEATRIZ ELISA. Datos registrales. T 41486 , F 2, S 8, H M 481196, I/A287 (29.05.23).
11 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA TORRE LOZANO CRISTINA. Datos registrales. T 41486 , F 2, S 8, H M 481196, I/A 286(30.03.23).
18 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ RODRIGUEZ JULIA. Datos registrales. T 41486 , F 1, S 8, H M 481196, I/A 285 (11.02.22).
08 de Noviembre de 2021Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41486 , F 1, S 8, H M 481196, I/A 284 (30.10.21).
18 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: IZQUIERDO VALERO JULIO. Apo.Sol.: IZQUIERDO VALERO JULIO. Datos registrales. T 41486 , F 1,S 8, H M 481196, I/A 283 ( 8.10.21).
23 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ RODRIGUEZ JULIA. Datos registrales. T 26705 , F 18, S 8, H M 481196, I/A 282(16.02.21).
31 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GIL CALAVERAS MARCELINO. Apoderado: GIL CALAVERAS MARCELINO. Datos registrales. T 26705 ,F 18, S 8, H M 481196, I/A 281 (23.12.19).
28 de Noviembre de 2019Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: NOVA PYC REAL ESTATE SL. Datos registrales. T 26705 , F 16, S 8, H M 481196,I/A 280 (21.11.19).
31 de Mayo de 2019Otros conceptos: CAMBIO DE CIF. Datos registrales. T 26705 , F 12, S 8, H M 481196, I/A276/M (24.05.19).
09 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ FERNANDO;SANCHEZ GARCIA-LOMAS BEATRIZ ELISA. Datos registrales.T 26705 , F 15, S 8, H M 481196, I/A 279 ( 2.04.19).
17 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: DE LOS ANGELES MARTIN JESUS CANDIDO. Datos registrales. T 26705 , F 15, S 8, H M 481196, I/A278 ( 8.05.18).
18 de Abril de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 26705 , F 15, S8, H M 481196, I/A 277 ( 6.04.17).