Actos BORME de Bolton Food Sl
08 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: URRAZA CRISTOBAL IBON. Apo.Manc.: BILBAO GARAY ALBERTO. Apo.Sol.: FRANCOIS LAURE.Datos registrales. T 3997, L 3997, F 220, S 8, H PO 22826, I/A 66 (31.08.23).
27 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: BILBAO GARAY ALBERTO;VICENTE HERNANDEZ OSCAR. Apoderado: COLMENARES MEZA KATTYYOMARA;VICENTE HERNANDEZ OSCAR. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 220, S 8, H PO 22826, I/A 65 (18.07.23).
09 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 59, S 8, H PO 22826, I/A 63 (29.12.22).
12 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ARIAS SANTIAGO JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: TEJEDOR GALLEGO JOSECIPRIANO. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 59, S 8, H PO 22826, I/A 62 (30.11.22).
09 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: FRANCO FRANQUET MARIA. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 59, S 8, H PO 22826, I/A 61 (1.08.22).
28 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: BILBAO GARAY ALBERTO. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 57, S 8, H PO 22826, I/A 58(17.06.22).
Nombramientos. Apoderado: SALVI SAMANTHA. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 58, S 8, H PO 22826, I/A 59 (17.06.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: BILBAO GARAY ALBERTO;VICENTE HERNANDEZ OSCAR. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 58,
24 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: VICENTE HERNANDEZ OSCAR. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 57, S 8, H PO 22826, I/A 57(17.06.22).
23 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GARAVILLA LEGARRA JUAN. Apoderado: MARTINEZ GARMENDIA CARLOS;BLANCO CID JOSEMANUEL;BILBAO GARAY ALBERTO;BUSTINZA SAN NICOLAS GAIZKA;FERNANDEZ ALVAREZ HECTOR MARTIN. Datosregistrales. T 3997, L 3997, F 55, S 8, H PO 22826, I/A 51 (16.06.22).
Nombramientos. Apoderado: ALONSO GARCIA AURORA. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 55, S 8, H PO 22826, I/A 52(16.06.22).
Nombramientos. Apoderado: COLMENARES MEZA KATTY YOMARA. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 55, S 8, H PO 22826,I/A 53 (16.06.22).
Nombramientos. Apoderado: COMESA脩A COSTAS PABLO. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 56, S 8, H PO 22826, I/A 54(16.06.22).
Nombramientos. Apoderado: TEJEDOR GALLEGO JOSE CIPRIANO. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 56, S 8, H PO 22826,I/A 55 (16.06.22).
Nombramientos. Apoderado: DIOS REY ANDRES MANUEL. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 56, S 8, H PO 22826, I/A 56(16.06.22).
12 de Febrero de 2021Cambio de domicilio social. C/ RUA JAIME AMEZAGA 144 (GROVE (O)). Datos registrales. T 3997, L 3997, F 52, S 8, H PO22826, I/A 50 ( 5.02.21).
08 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORRALES GARAVILLA JUAN. Nombramientos. Apo.Sol.: BILBAO GARAY ALBERTO.Consejero: VICENTE HERNANDEZ OSCAR. Presidente: VICENTE HERNANDEZ OSCAR. Consejero: BILBAO GARAYALBERTO;ARIAS SANTIAGO JOSE MANUEL. SecreNoConsj: PALOMINO BILBAO CARLOS ANTONIO. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. El socio 煤nico decide derogar la totalidad de losestatutos sociales y la aprobaci贸n de unos nuevos. Datos registrales. T 3997, L 3997, F 52, S 8, H PO 22826, I/A 49 (30.06.20).