Buscador CIF Logo

Actos BORME Bombardier Transportation Participations Spain Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bombardier Transportation Participations Spain Sociedad Limitada

Actos BORME Bombardier Transportation Participations Spain Sociedad Limitada - B95509477

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Bombardier Transportation Participations Spain Sociedad Limitada con CIF B95509477

馃敊 Perfil de Bombardier Transportation Participations Spain Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Bombardier Transportation Participations Spain Sociedad Limitada

02 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: DIEZ SASTRE FERNANDO. Datos registrales. T 4904 , F 91, S 8, H BI 51193, I/A 17 (25.01.22).

Nombramientos. Apoderado: NAVAZO CUADRADO PABLO. Datos registrales. T 4904 , F 91, S 8, H BI 51193, I/A 18 (25.01.22).

23 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO MOREDA MARTA. Con.Delegado: ALONSO MOREDA MARTA. Secretario: ALONSOMOREDA MARTA. Consejero: BOELS PETER LEO MARIE JOSEPHE. Cons.Del.Man: BOELS PETER LEO MARIEJOSEPHE;TORRES MINGUEZ DAVID. Presidente: TORRES MINGUEZ DAVID. Nombramientos. Consejero: MAESTU MIEDESLEOPOLDO;GOMEZ PESQUERA ALBERTO;MORALES CALVO MARIA ANGELES. Presidente: MAESTU MIEDES LEOPOLDO.Secretario: MORALES CALVO MARIA ANGELES. Cons.Del.Sol: MAESTU MIEDES LEOPOLDO;GOMEZ PESQUERAALBERTO;MORALES CALVO MARIA ANGELES;TORRES MINGUEZ DAVID. Otros conceptos: Se fija en cuatro el n煤mero deconsejeros. Datos registrales. T 4904 , F 91, S 8, H BI 51193, I/A 16 (15.06.21).

05 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ ALVAREZ OSCAR. Presidente: VAZQUEZ ALVAREZ OSCAR. Cons.Del.Man: VAZQUEZALVAREZ OSCAR. Nombramientos. Consejero: TORRES MINGUEZ DAVID. Presidente: TORRES MINGUEZ DAVID.Cons.Del.Man: TORRES MINGUEZ DAVID. Datos registrales. T 4904 , F 90, S 8, H BI 51193, I/A 15 (23.03.21).

30 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DOUZENEL DAVID. Con.Delegado: DOUZENEL DAVID. Nombramientos. Consejero: BOELSPETER LEO MARIE JOSEPHE. Cons.Del.Man: BOELS PETER LEO MARIE JOSEPHE. Datos registrales. T 4904 , F 90, S 8, H BI51193, I/A 14 (17.04.19).

09 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRIETA NAVARIDAS JAIME. Secretario: ARRIETA NAVARIDAS JAIME. Con.Delegado: ARRIETANAVARIDAS JAIME. Nombramientos. Consejero: ALONSO MOREDA MARTA. Con.Delegado: ALONSO MOREDA MARTA.Secretario: ALONSO MOREDA MARTA. Datos registrales. T 4904 , F 28, S 8, H BI 51193, I/A 13 ( 1.08.18).

21 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: RENGIFO ABBAD ALVARO. Presidente: RENGIFO ABBAD ALVARO. Consejero: RENGIFOABBAD ALVARO. Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ ALVAREZ OSCAR. Presidente: VAZQUEZ ALVAREZ OSCAR.Cons.Del.Man: VAZQUEZ ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 4904 , F 28, S 8, H BI 51193, I/A 12 ( 7.06.17).

17 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: URIARTE SANCHEZ JOSE. Cons.Del.Man: URIARTE SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 4904 ,F 28, S 8, H BI 51193, I/A 11 ( 7.05.13).

20 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: LEZAMIZ ELORDUY GARBI脩E;ARRIETA NAVARIDAS JAIME. Datos registrales. T 4904 , F 27, S 8, HBI 51193, I/A 10 ( 7.03.12).

30 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: ALAIN KIRCHER SYLVAIN. Consejero: ALAIN KIRCHER SYLVAIN. Nombramientos.Consejero: DOUZENEL DAVID. Con.Delegado: DOUZENEL DAVID. Datos registrales. T 4904 , F 27, S 8, H BI 51193, I/A 9(16.11.11).

05 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: URIARTE SANCHEZ JOSE. Nombramientos. Consejero: RENGIFO ABBAD ALVARO. Presidente:RENGIFO ABBAD ALVARO. Cons.Del.Man: RENGIFO ABBAD ALVARO. Datos registrales. T 4904 , F 26, S 8, H BI 51193, I/A 8(21.07.11).

28 de Enero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 211,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.321,00 Euros. Datos registrales. T 4904 , F 25, S 8, H BI51193, I/A 7 (17.01.11).

25 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 52,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.110,00 Euros. Datos registrales. T 4904 , F 25, S 8, H BI 51193,I/A 6 (15.02.10).

27 de Enero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 52,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.058,00 Euros. Datos registrales. T 4904 , F 24, S 8, H BI 51193,I/A 5 ( 8.01.10).

30 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALONSO MOREDA MARTA. Nombramientos. Consejero: ARRIETA NAVARIDAS JAIME.Secretario: ARRIETA NAVARIDAS JAIME. Consejero: URIARTE SANCHEZ JOSE. Presidente: URIARTE SANCHEZ JOSE.Consejero: ALAIN KIRCHER SYLVAIN. Cons.Del.Man: URIARTE SANCHEZ JOSE;ALAIN KIRCHER SYLVAIN. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. 20. Administraci贸n y

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n