Actos BORME de Bonechamp Sociedad Limitada
25 de Mayo de 2022Otros conceptos: Decreto de INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 15.743'90 euros. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8,H AB 12173, I/A 24 (18.05.22).
Otros conceptos: Decreto de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 9.411'32 euros. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8, HAB 12173, I/A 25 (18.05.22).
Otros conceptos: Decreto de INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 11.870'93 euros. Datos registrales. T 1046, L 810, F 177, S 8,H AB 12173, I/A 26 (18.05.22).
27 de Abril de 2022Otros conceptos: Decreto de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 11.218'19 euros. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8,H AB 12173, I/A 23 (19.04.22).
28 de Febrero de 2022Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 6.634,75 euros. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8, H AB 12173,I/A 22 (18.02.22).
29 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: YA脩EZ MARTINEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8, H AB 12173, I/A 21(22.06.21).
25 de Junio de 2021Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 18.469,54 euros. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8, H AB12173, I/A 20 (18.06.21).
25 de Mayo de 2021Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 10.733,49 euros. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8, H AB12173, I/A 19 (17.05.21).
22 de Marzo de 2021Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 12.455,41 euros. Datos registrales. T 1028, L 792, F 133, S 8, H AB12173, I/A 18 (12.03.21).
11 de Marzo de 2021Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 46.613,74 euros. Datos registrales. T 989, L 753, F 152, S 8, H AB 12173,I/A 17 ( 4.03.21).
10 de Marzo de 2021Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 35.311,93 euros. Datos registrales. T 989, L 753, F 152, S 8, H AB 12173,I/A 15 ( 3.03.21).
Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 15.391,54 euros. Datos registrales. T 989, L 753, F 152, S 8, H AB 12173,I/A 16 ( 3.03.21).
29 de Septiembre de 2020Otros conceptos: INSOLVENCIA TOTAL, por importe de 9.374,38 euros. Datos registrales. T 989, L 753, F 152, S 8, H AB 12173,I/A 14 (22.09.20).
12 de Agosto de 2020Otros conceptos: iNSOLVENCIA tOTAL POR importe de 7.848'31 euros. Datos registrales. T 989, L 753, F 152, S 8, H AB 12173,I/A 13 ( 5.08.20).
13 de Marzo de 2020Nombramientos. Auditor: KRESTON IBERAUDIT APM SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 989, L 753, F 152, S 8, H AB12173, I/A 12 ( 6.03.20).
09 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: YA脩EZ MARTINEZ FRANCISCO;SAMPAIO TEIXEIRA RUI FERNANDO. Nombramientos. Apo.Manc.:YA脩EZ MARTINEZ FRANCISCO;TEIXEIRA LEITE MONTEIRO MANUELA MARIA. Datos registrales. T 891, L 655, F 176, S 8, H AB12173, I/A 11 ( 2.01.18).
01 de Agosto de 2014Nombramientos. Auditor: LOMAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 891, L 655, F 176, S 8,H AB 12173, I/A 10 (25.07.14).
25 de Enero de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: YA脩EZ MARTINEZ FRANCISCO;MARCOS GONZALEZ IDAIRA. Nombramientos. Apo.Manc.: YA脩EZMARTINEZ FRANCISCO;SAMPAIO TEIXEIRA RUI FERNANDO. Datos registrales. T 816, L 580, F 221, S 8, H AB 12173, I/A 9(14.01.10).
23 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: YA脩EZ MARTINEZ FRANCISCO;MARCOS GONZALEZ IDAIRA. Datos registrales. T 816, L 580, F221, S 8, H AB 12173, I/A 8 (14.12.09).
11 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: YA脩EZ MARTINEZ FRANCISCO;YA脩EZ MARTINEZ JOSE;NAVALON NAVALON ANDRES.Nombramientos. Adm. Unico: VARANDAS DE SOUSA ARTUR JOSE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 816, L 580, F 220, S 8, H AB 12173, I/A 7 (1.12.09).
06 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: YA脩EZ MARTINEZ ALFREDO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 578.800,00 Euros. ResultanteSuscrito: 1.443.800,00 Euros. Datos registrales. T 816, L 580, F 220, S 8, H AB 12173, I/A 6 (28.10.09).
03 de Noviembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 540.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 865.000,00 Euros. Datos registrales. T 816, L 580, F 219, S8, H AB 12173, I/A 5 (26.10.09).