Actos BORME de Bongard Iberia Sa
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. AUDIT.CUENT.: LOPEZ DELGADO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 43503 , F 114, S 8,H B 79168, I/A 53 (18.09.23).
09 de Diciembre de 2021Nombramientos. ADM.UNICO: AFE BAKERY SAS. Datos registrales. T 43503 , F 114, S 8, H B 79168, I/A 52 (29.11.21).
10 de Marzo de 2021Revocaciones. APODERADO: SANCHEZ INFANTE PABLO. Datos registrales. T 43503 , F 114, S 8, H B 79168, I/A 51 ( 2.03.21).
23 de Diciembre de 2020Revocaciones. APOD.MANCOMU: SANCHEZ INFANTE PABLO. Datos registrales. T 43503 , F 113, S 8, H B 79168, I/A 50(15.12.20).
15 de Septiembre de 2020Nombramientos. APOD.MANCOMU: PUJADAS ORTIZ IVAN. Datos registrales. T 43503 , F 113, S 8, H B 79168, I/A 49 ( 7.09.20).
28 de Diciembre de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 43503 , F 113, S 8, H B 79168, I/A 48 (19.12.17).
07 de Junio de 2017Nombramientos. APOD.MANCOMU: BENOIT THIERRY SEVIN;SANCHEZ INFANTE PABLO. Datos registrales. T 43503 , F 113, S8, H B 79168, I/A 47 (30.05.17).
30 de Mayo de 2017Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: AFE BAKERY S.A.S. Datos registrales. T43503 , F 112, S 8, H B 79168, I/A 46 (23.05.17).
22 de Marzo de 2017Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LORENTE CABALLERO JOSE;BENOIT THIERRY SEVIN. Nombramientos. ADM.UNICO: AFEBAKERY SAS. REPR.143 RRM: PEIROTES LONGACRE TRISTAN JACK. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 7,11,25,26,27,28,30,31,37 Y 38 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ORGANO DE ADMINISTRACION. Datosregistrales. T 43503 , F 111, S 8, H B 79168, I/A 45 ( 9.03.17).
10 de Noviembre de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LORENTE CABALLERO JOSE;ALAIN LOUIS FRANCIS PERU. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.:LORENTE CABALLERO JOSE;BENOIT THIERRY SEVIN. Datos registrales. T 43503 , F 111, S 8, H B 79168, I/A 44 ( 2.11.15).
31 de Marzo de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 43503 , F 111, S 8, H B 79168, I/A 42(20.03.14).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KMPG AUDITORES SL. Datos registrales. T 43503 , F 111, S 8, H B 79168, I/A 43 (20.03.14).
14 de Diciembre de 2012Nombramientos. APODERADO: BENOIT THIERRY SEVIN;SANCHEZ INFANTE PABLO. Datos registrales. T 31613 , F 170, S 8, HB 79168, I/A 40 ( 5.12.12).
Revocaciones. APODERADO: SANCHEZ INFANTE PABLO;SANCHEZ INFANTE PABLO. Datos registrales. T 31613 , F 170, S 8,H B 79168, I/A 41 ( 5.12.12).
13 de Mayo de 2011Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LORENTE CABALLERO JOSE;DIDIER JEAN PAUL PERONNE. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: LORENTE CABALLERO JOSE;ALAIN LOUIS FRANCIS PERU. Datos registrales. T 31613 , F 170, S 8, H B 79168,I/A 39 ( 3.05.11).
15 de Diciembre de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31613 , F 169, S 8, H B 79168, I/A 38 ( 2.12.09).
28 de Abril de 2009Otros conceptos: CONSTANCIA DEL CAMBIO DE LA FORMA SOCIAL Y DEL NUMERO DE IDENTIFICACION REGISTRAL DELACCIONISTA UNICO,PASANDO A DENOMINARSE:"BONGARD INDUSTRIES, S.A.S.". Datos registrales. T 31613 , F 169, S 8, H B79168, I/A 37 (15.04.09).
14 de Abril de 2009Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: DIDIER JEAN PAUL PERONNE. Datos registrales. T 31613 , F 168, S 8, H B 79168, I/A 35(31.03.09).
Nombramientos. APODERADO: SANCHEZ INFANTE PABLO. Datos registrales. T 31613 , F 168, S 8, H B 79168, I/A 36(31.03.09).
23 de Febrero de 2009Revocaciones. APODERADO: GALINDO PIÑERO DOLORES. Datos registrales. T 31613 , F 168, S 8, H B 79168, I/A 34(11.02.09).
10 de Febrero de 2009Revocaciones. APODERADO: CAMPANY FARRELL FRANCESC. Datos registrales. T 31613 , F 168, S 8, H B 79168, I/A 33(29.01.09).