Actos BORME de Boreas Eolica 2 Sa
21 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARREDO LOPEZ JORGE;LEMA CIRONE GABRIEL;OLMO JIMENEZ ANDRES;MARCO NOAINMARIA CRISTINA;DEL HOYO ESPUELAS MARIA GEMA. Datos registrales. T 37284 , F 130, S 8, H M 664918, I/A 27 (14.04.23).
13 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARREDO LOPEZ JORGE;LEMA CIRONE GABRIEL;OLMO JIMENEZ ANDRES;MARCO NOAINMARIA CRISTINA. Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE;LEMA CIRONE GABRIEL;OLMO JIMENEZANDRES;MARCO NOAIN MARIA CRISTINA;CANO CARO ANA. Datos registrales. T 37284 , F 129, S 8, H M 664918, I/A 26 (6.03.23).
30 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER;DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER. Datosregistrales. T 37284 , F 129, S 8, H M 664918, I/A 25 (23.01.23).
15 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARREDO LOPEZ JORGE;LEMA CIRONE GABRIEL;OLMO JIMENEZ ANDRES;MARCO NOAINMARIA CRISTINA. Datos registrales. T 37284 , F 128, S 8, H M 664918, I/A 24 ( 8.12.22).
16 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARREDO LOPEZ JORGE;PRIETO MONTERRUBIO ELOY;LEMA CIRONE GABRIEL;OLMOJIMENEZ ANDRES;MARCO NOAIN MARIA CRISTINA;DEL HOYO ESPUELAS MARIA GEMA. Apoderado: CASTELLVI POVEDAJOSE MANUEL. Datos registrales. T 37284 , F 128, S 8, H M 664918, I/A 23 ( 9.03.22).
28 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PRIETO MONTERRUBIO ELOY. Nombramientos. Adm. Solid.: CANO CARO ANA. Datosregistrales. T 37284 , F 128, S 8, H M 664918, I/A 22 (21.02.22).
01 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARREDO LOPEZ JORGE;LEMA CIRONE GABRIEL;OLMO JIMENEZ ANDRES;MARCO NOAINMARIA CRISTINA;DEL HOYO ESPUELAS MARIA GEMA. Datos registrales. T 37284 , F 127, S 8, H M 664918, I/A 21 (25.01.22).
27 de Octubre de 2021Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37284 , F 127, S 8, H M 664918, I/A 19 (20.10.21).
Cambio de domicilio social. AVDA DE AMERICA 38 (MADRID). Datos registrales. T 37284 , F 127, S 8, H M 664918, I/A 20(20.10.21).
20 de Julio de 2021Otros conceptos: Revocados los poderes otorgados a D. Carlos Javier Alvarez Fernández con DNI 43496304-S, D. Joan Felip Fontcon DNI 77603184-K, en escritura otorgada el 25 de noviembre de 2009 ante el notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras conel número 2.852 de su protocolo, Inscripción 14ª de traslado.Revocados los poderes otorgados a D. Enrique Berenguer Marsal con DNI46223396-C, D. José Luis Galán Ganchegui con DNI 32393293-R, en escritura otorgada el 25 de noviembre de 2009 ante el notario deMadrid, D. Pedro de la Herrán Matorras con el número 2.852 de protocolo, Inscripción 14ª de traslado.Revocados los poderesotorgados a Dª. Rosa Juan Ferrer con DNI 41447266-R, D. Juan José Rivero Aranda con DNI 2527171-T, en la escritura otorgada el25 de noviembre de 2009 ante el notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras con el número 2.852 de su protocolo, Inscripción14ª de traslado. Revocados los poderes otorgados a D. Jordi Totusaus Calve con DNI 36094632-J, D. Ramón Trepat Font con DNI38117797-N, en la escritura otorgada el 25 de noviembre de 2009 ante el notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras con elnúmero 2.852 de su protocolo, Inscripción 14ª de traslado. Revocados los poderes otorgados a Dª. Hila Barcas Lewkowicz con DNI35090003-F, Dª. Marta Mayor Bellosta con DNI 35078488-S, en la escritura otorgada el 25 de noviembre de 2009 ante el notario deMadrid, D. Pedro de la Herrán Matorras con el número 2.852 de su protocolo, Inscripción 14ª de traslado.Revocados los poderesotorgados a Dª. Almudena Lombardía Escudero con DNI 32792315-L, D. Javier García Esteban con DNI 50810125-C, en escrituraotorgada el 25 de noviembre de 2009 ante el notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras con el número 2.852 de protocolo,Inscripción 14ª de traslado.Revocados los poderes a Dª. Irene Velasco Miranda con DNI 5414259-J, en la escritura otorgada el 25 denoviembre de 2009 ante el notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras con el número 2.852 de su protocolo, Inscripción 14ª detraslado. Revocados los poderes otorgados a D. ANTONIO GALLART GABAS con DNI 40876041-G, en la escritura otorgada el 30 dejulio de 2015 ante el notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras con el número 2.131 de su protocolo. Inscripción 33ª detraslado. Revocados los poderes otorgados a Dª. MARIA DIAZ DE TERAN LOPEZ con DNI 33524394-P, en la escritura otorgada el 30de julio de 2015 ante el notario de Madrid, D. Enrique Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro con el número 781 de su protocolo.Inscripción 9ª. Datos registrales. T 37284 , F 126, S 8, H M 664918, I/A 18 (13.07.21).
19 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ PERDICES IGNACIO;DIAZ DE TERAN LOPEZ MARIA. Datos registrales. T 37284 , F 126, S 8,H M 664918, I/A 17 (12.05.21).
14 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCO NOAIN MARIA CRISTINA;DEL HOYO ESPUELAS MARIA GEMA. Datos registrales. T37284 , F 125, S 8, H M 664918, I/A 15 ( 7.04.21).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SAMANO CARLOS ENRIQUE. Apo.Manc.: FERNANDEZ ROSELLO EVA. Apo.Sol.:FERNANDEZ ROSELLO EVA. Datos registrales. T 37284 , F 126, S 8, H M 664918, I/A 16 ( 7.04.21).
17 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARCO NOAIN MARIA CRISTINA. Nombramientos. Adm. Solid.: PRIETO MONTERRUBIOELOY. Datos registrales. T 37284 , F 125, S 8, H M 664918, I/A 14 ( 9.02.21).
26 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL;PERIS CAMINERO
05 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL;FELIP FONT JOAN;MERINO HERNANDEZ SERVANDO;FELIP FONTJOAN;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;RIVEROARANDA JUAN JOSE;TOTUSAUS CALVE JORDI;BARCAS LEWKOWICZ HILA;GOMEZ FEBREL BALTASAR. Apo.Sol.: RIVEROARANDA JUAN JOSE. Datos registrales. T 37284 , F 124, S 8, H M 664918, I/A 12 (29.05.20).
17 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL;PERIS CAMINERO ANA MARIA;PRIETO MONTERRUBIOELOY;LEMA CIRONE GABRIEL;MARCO NOAIN MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 37284 , F 123, S 8, H M 664918, I/A 11(10.03.20).
14 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: EGEA KRAUEL JOSE MARIA. Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ SANCHEZ DAVID. Datosregistrales. T 37284 , F 122, S 8, H M 664918, I/A 10 ( 7.08.19).
22 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MARCO NOAIN MARIA CRISTINA;RIVERO ARANDA JUAN JOSE. Datos registrales. T 37284 , F 121,S 8, H M 664918, I/A 8 (14.05.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ ROSELLO EVA. Apo.Sol.: FERNANDEZ ROSELLO EVA;DIAZ TERAN LOPEZ MARIA.Datos registrales. T 37284 , F 122, S 8, H M 664918, I/A 9 (14.05.19).
21 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA CUADRA MOYA JOSE LUIS;DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER. Presidente: DELA CUADRA MOYA JOSE LUIS. Consejero: GONZALEZ SAMANO CARLOS ENRIQUE. SecreNoConsj: ROMANS GARCIA JORDI.Nombramientos. Adm. Solid.: SAN EMETERIO SIMON JESUS;MARCO NOAIN MARIA CRISTINA. Modificaciones estatutarias.Refundición de estatutos.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradoressolidarios. Datos registrales. T 37284 , F 119, S 8, H M 664918, I/A 7 (13.05.19).
05 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: CASTELLVI POVEDA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 37284 , F 119, S 8, H M 664918, I/A 6(25.10.18).
19 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: MENENDEZ FERNANDEZ JAUME;CLAVER LACASTA CARLOS;BUEY CASAUS EDUARDO;BUEYCASAUS EDUARDO;MENENDEZ FERNANDEZ JAUME. Datos registrales. T 37284 , F 118, S 8, H M 664918, I/A 5 (12.07.18).
12 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BUEY CASAUS EDUARDO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SAMANO CARLOSENRIQUE. Datos registrales. T 37284 , F 118, S 8, H M 664918, I/A 4 ( 5.07.18).
08 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: SANTALO LLUCH JOSEP;ILLANA PEREZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 37284 , F 118, S 8, HM 664918, I/A 3 ( 1.03.18).
07 de Marzo de 2018Cambio de domicilio social. AVDA DE SAN LUIS 77 (MADRID). Datos registrales. T 37284 , F 117, S 8, H M 664918, I/A 2(28.02.18).
19 de Octubre de 2017Nombramientos. CONSEJERO: BUEY CASAUS EDUARDO. Datos registrales. T 44047 , F 199, S 8, H B 445622, I/A 42(11.10.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: ALBA VALMORISCO RICARDO. Datos registrales. T 44047 , F 199, S 8, H B 445622, I/A 43(11.10.17).
17 de Octubre de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44047 , F 198, S 8, H B445622, I/A 40 ( 6.10.17).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 44047 , F 198, S 8, H B 445622, I/A 41 ( 6.10.17).
13 de Julio de 2017Revocaciones. APOD.SOL/MAN: JARDON CAVERO ANA MARIA;PEÑARRUBIA SANCHEZ SALVADOR. Datos registrales. T44047 , F 198, S 8, H B 445622, I/A 39 ( 6.07.17).
22 de Diciembre de 2016Revocaciones. SECR.NO CONS: CEPEDA MORRAS JAVIER. Nombramientos. SECR.NO CONS: ROMANS GARCIA JORDI.Datos registrales. T 44047 , F 198, S 8, H B 445622, I/A 38 (14.12.16).
12 de Agosto de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44047 , F 197, S 8, H B445622, I/A 37 ( 4.08.16).
11 de Diciembre de 2015Revocaciones. SECR.NO CONS: ALCANTARA BRAVO MARIA MACARENA. Nombramientos. SECR.NO CONS: CEPEDAMORRAS JAVIER. Datos registrales. T 44047 , F 197, S 8, H B 445622, I/A 36 ( 1.12.15).
27 de Octubre de 2015Revocaciones. APODERAD.SOL: SERRANO PATZIG JAVIER. Datos registrales. T 44047 , F 197, S 8, H B 445622, I/A 35(19.10.15).
14 de Octubre de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44047 , F 197, S 8, H B445622, I/A 34 ( 5.10.15).
06 de Octubre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: SERRANO PATZIG JAVIER;GUERRA REHN DAVID. PRESIDENTE: SERRANO PATZIG JAVIER.Nombramientos. CONSEJERO: DE LA CUADRA MOYA JOSE LUIS. PRESIDENTE: DE LA CUADRA MOYA JOSE LUIS.CONSEJERO: JAVIER DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA. Datos registrales. T 44047 , F 195, S 8, H B 445622, I/A 32(29.09.15).
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: GUERRA REHN DAVID;GALLART GABAS ANTONIO;GUERRA REHN DAVID. Nombramientos.APOD.SOL/MAN: DE LA CUADRA MOYA JOSE LUIS. Datos registrales. T 4447 , F 195, S 8, H B 445622, I/A 33 (29.09.15).
05 de Agosto de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: SERRANO PATZIG JAVIER;DE LA CUADRA MOYA JOSE LUIS;GONZALEZ SAMANOCARLOS ENRIQUE;DE LOS RIOS ARGENTA JAVIER;FERRERO CARBAJO JUAN. Datos registrales. T 44047 , F 195, S 8, H B445622, I/A 31 (29.07.15).
30 de Abril de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: ALCANTARA BRAVO MACARENA;BARRIONUEVO HUELAMO MARTA. Datos registrales. T
08 de Septiembre de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44047 , F 194, S 8, H B445622, I/A 29 (29.08.14).
06 de Mayo de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: MUÑOZ SANCHEZ DAVID. Datos registrales. T 44047 , F 193, S 8, H B 445622, I/A 28(25.04.14).
27 de Enero de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA JAVIER;LUNA RODRIGUEZ IÑIGO. Datos registrales.T 44047 , F 193, S 8, H B 445622, I/A 27 (17.01.14).
19 de Diciembre de 2013Cambio de domicilio social. PZ DEL GAS Num.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 44047 , F 193, S 8, H B 445622, I/A 26(12.12.13).
09 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1015 , F 90, S 8, H NA 20424, I/A23 (26.09.13).
17 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: YBERN ARTOLA PEDRO;GALAN GANCHEGUI JOSE LUIS. Datos registrales. T 1015 , F 90, S 8, HNA 20424, I/A 22 (10.04.13).
19 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apoderado: JUAN FERRER ROSA. Datos registrales. T 1015 , F 90, S 8, H NA 20424, I/A 21 (12.12.12).
14 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRIONUEVO HUELAMO MARTA. Secretario: BARRIONUEVO HUELAMO MARTA.Nombramientos. Consejero: GUERRA REHN DAVID. SecreNoConsj: ALCANTARA BRAVO MARIA MACARENA. Reelecciones.Consejero: BUEY CASAUS EDUARDO. Datos registrales. T 1015 , F 89, S 8, H NA 20424, I/A 19 ( 3.08.12).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1015 , F 90, S 8, H NA 20424, I/A20 ( 3.08.12).
24 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ FERNANDEZ JAUME;GOMEZ FEBREL BALTASAR;ILLANA PEREZ JOSEANTONIO;PARRA ROMERO MARIA INMACULADA. Datos registrales. T 1015 , F 88, S 8, H NA 20424, I/A 18 (10.05.12).
18 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1015 , F 88, S 8, H NA 20424, I/A17 ( 5.10.11).
06 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: GUERRA REHN DAVID. Consejero: GUERRA REHN DAVID. Nombramientos. Consejero:SERRANO PATZIG JAVIER. Presidente: SERRANO PATZIG JAVIER. Datos registrales. T 1015 , F 88, S 8, H NA 20424, I/A 16(14.09.11).
22 de Octubre de 2010Reelecciones. Consejero: GUERRA REHN DAVID;BARRIONUEVO HUELAMO MARTA. Datos registrales. T 1015 , F 88, S 8, HNA020424, I/A00015 (11.10.10).
29 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL;GALLART GABASANTONIO;EGEA KRAUEL JOSE MARIA;FELIP FONT JOAN;BERENGUER MARSAL ENRIQUE;GUERRA REHN DAVID;JARDONCAVERO ANA MARIA;GALAN GANCHEGUI JOSE LUIS;JUAN FERRER ROSA;RIVERO ARANDA JUAN JOSE;BUEY CASAUSEDUARDO;TOTUSAUS CALVE JORDI;TREPAT FONT RAMON;BARCAS LEWKOWICZ HILA;MAYOR BELLOSTAMARTA;LOMBARDIA ESCUDERO ALMUDENA;GARCIA ESTEBAN JAVIER;VELASCO MIRANDA IRENE. Datos registrales. T 1015, F 87, S 8, H NA020424, I/A00014 (15.12.09).
17 de Marzo de 2009Revocaciones. Apoderado: VALDES FIGUEROA ALBERTO;VALDES FIGUEROA ALBERTO;BERENGUER MARSAL ENRIQUE.Nombramientos. Apoderado: BERENGUER MARSAL ENRIQUE;BUEY CASAUS EDUARDO;BARCAS LEWKOWICHILA;BERENGUER MARSAL ENRIQUE. Datos registrales. T 1015 , F 86, S 8, H NA020424, I/A00013 ( 6.03.09).