Actos BORME de Bosa Del Ebro Sociedad Limitada
17 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ANTONIO YEPES ADOLFO;NU脩EZ SANCHEZ-ARJONA ANGEL;COLCHERO RAZOANTONIO;BARTES SANCHEZ MANEL. Datos registrales. T 4462 , F 91, S 8, H Z 50980, I/A 25 (11.11.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LOPEZ VICTOR. Datos registrales. T 4462 , F 92, S 8, H Z 50980, I/A 26 (11.11.22).
16 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: WHITE MARTIN RAMON;OSCA GIMENO JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL;SANCHEZARANDA LOURDES. Presidente: WHITE MARTIN RAMON. Nombramientos. Consejero: LOPEZ BRIZZOLIS JOSEANTONIO;ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T4327 , F 194, S 8, H Z 50980, I/A 22 ( 5.08.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4327 , F 194, S 8, H Z 50980, I/A 23( 5.08.22).
Modificaciones estatutarias. "Art铆culo 13.- Reglas. En todo lo no previsto en estos Estatutos se aplicar谩n a la Junta General lasnormas recogidas en la Ley de Sociedades de Capital, con las siguientes especialidades: 1. La Junta General ser谩 convocadamediante comunicaci贸n individual y escrita - correo certificado, burofax o "Art.15.bis. Consejo telem谩tico. Se admite expresamente lacelebraci贸n de reuni贸n del Consejo de Administraci贸n mediante sistemas de telecomunicaci贸n siempre que los asistentes puedan serdebidamente identificados y puedan ejercer sus derechos de informaci贸n y voto. En este caso, la sesi贸n del. Datos registrales. T4462 , F 90, S 8, H Z 50980, I/A 24 ( 5.08.22).
14 de Julio de 2020Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4327 , F193, S 8, H Z 50980, I/A 20 ( 7.07.20).
11 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LAS MORENAS MONEO ENRIQUE. Presidente: DE LAS MORENAS MONEO ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: WHITE MARTIN RAMON. Presidente: WHITE MARTIN RAMON. Datos registrales. T 4327 , F 193, S8, H Z 50980, I/A 18 ( 4.06.19).
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4327 , F 193, S 8, H Z 50980, I/A 19 ( 4.06.19).
21 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: REDONDO SANCHEZ JESUS ARSENIO;GRANERO ESCUDERO ANABEL;CALVO MARINNATALIA;PI脩ERO GUERRERO JUAN ANTONIO;SANCHEZ MARTIN ANA. Datos registrales. T 4327 , F 190, S 8, H Z 50980, I/A 15(13.05.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLEGO RAMOS PAULA. Datos registrales. T 4327 , F 190, S 8, H Z 50980, I/A 16 (13.05.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAPUOZZO LUCA. Datos registrales. T 4327 , F 192, S 8, H Z 50980, I/A 17 (13.05.19).
27 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: OSCA GIMENO JORGE;PEREZ FRANCES FRANCISCO JAVIER;WHITE MARTIN RAMON. Datosregistrales. T 4327 , F 188, S 8, H Z 50980, I/A 13 (21.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: WHITE MARTIN RAMON. Datos registrales. T 4327 , F 189, S 8, H Z 50980, I/A 14 (21.06.18).
28 de Marzo de 2018P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BANCALE SERVICIOS INTEGRALES SL.Nombramientos. SecreNoConsj: PACHECO PLAZA TERESA. Consejero: DE LAS MORENAS MONEO ENRIQUE. Presidente: DELAS MORENAS MONEO ENRIQUE. Consejero: GRACIA TRULLENQUE JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL;OSCAGIMENO JORGE;SANCHEZ ARANDA LOURDES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR JOAQUIN AZNAR MOLINA 2 (ZARAGOZA). Datosregistrales. T 3815 , F 13, S 8, H Z 50980, I/A 4 (21.03.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: GRACIA TRULLENQUE JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3815 , F 13,S 8, H Z 50980, I/A 5 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: MAGLIOCCO NICHOLAS. Datos registrales. T 3815 , F 13, S 8, H Z 50980, I/A 6 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA NOMBELA ADOLFO. Datos registrales. T 3815 , F 14, S 8, H Z 50980, I/A 7 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROBLES GARCIA MARIA EMMA;GARCIA CATTANEO GONZALO;ALVAREZ OREJASGUILLERMO;PRADO VILLANUEVA MIGUEL;LOPEZ FERNANDEZ IVAN;RODRIGUEZ VIDAL ANTONIO MARIO. Datos registrales.T 3815 , F 15, S 8, H Z 50980, I/A 8 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN GIL ELENA;AREVALO BARJOLA CARLOS. Datos registrales. T 3815 , F 16, S 8, H Z50980, I/A 9 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA CATTANEO GONZALO;PRADO VILLANUEVA MIGUEL;LOPEZ FERNANDEZ IVAN;RIQUELMEBROTONS ANTONIO;LOPEZ DE VILLALTA Y PEINADO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4327 , F 186, S 8, H Z 50980,I/A 10 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREA SUAREZ DE URBINA SARA;OSCA GIMENO JORGE. Datos registrales. T 4327 , F 186, S 8, HZ 50980, I/A 11 (21.03.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERENGUER GOMEZ VIRGINIA;FERNANDEZ SANCHEZ ELENA;REILLO ALFONSOOLGA;PACHECO PLAZA TERESA;RIQUELME BROTONS ANTONIO;LOPEZ DE VILLALTA Y PEINADO FRANCISCO JAVIER;DEMENA PERNIL PABLO. Datos registrales. T 4327 , F 187, S 8, H Z 50980, I/A 12 (21.03.18).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: GRACIA TRULLENQUE JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3815 , F10, S 8, H Z 50980, I/A 3 (18.07.17).
30 de Marzo de 2016Cambio de domicilio social. PLAZA SALAMERO 14 ENTR. C (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3815 , F 10, S 8, H Z 50980, I/A 2(17.03.16).
29 de Diciembre de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.12.10. Objeto social: a) el estudio, implementaci贸n y explotaci贸n de instalaciones deaprovechamiento a partir de la energ铆a e贸lica. b) la obtenci贸n y utilizaci贸n de derechos, concesiones, habilitaciones y autorizacionesadministrativas que sean necesarias para el desarrollo de las actividades descritas en el apartado a). Domicilio: C/ ALBAREDA 1B 2潞 B(ZARAGOZA). Capital: 3.010,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BANCALE SERVICIOS INTEGRALES SL.Nombramientos. Adm. Unico: BANCALE SERVICIOS INTEGRALES SL. Datos registrales. T 3815 , F 9, S 8, H Z 50980, I/A 1(16.12.10).