Buscador CIF Logo

Actos BORME Bosa Del Ebro Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bosa Del Ebro Sociedad Limitada

Actos BORME Bosa Del Ebro Sociedad Limitada - B99299505

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Bosa Del Ebro Sociedad Limitada con CIF B99299505

馃敊 Perfil de Bosa Del Ebro Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Bosa Del Ebro Sociedad Limitada

17 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ANTONIO YEPES ADOLFO;NU脩EZ SANCHEZ-ARJONA ANGEL;COLCHERO RAZOANTONIO;BARTES SANCHEZ MANEL. Datos registrales. T 4462 , F 91, S 8, H Z 50980, I/A 25 (11.11.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LOPEZ VICTOR. Datos registrales. T 4462 , F 92, S 8, H Z 50980, I/A 26 (11.11.22).

16 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: WHITE MARTIN RAMON;OSCA GIMENO JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL;SANCHEZARANDA LOURDES. Presidente: WHITE MARTIN RAMON. Nombramientos. Consejero: LOPEZ BRIZZOLIS JOSEANTONIO;ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T4327 , F 194, S 8, H Z 50980, I/A 22 ( 5.08.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4327 , F 194, S 8, H Z 50980, I/A 23( 5.08.22).

Modificaciones estatutarias. "Art铆culo 13.- Reglas. En todo lo no previsto en estos Estatutos se aplicar谩n a la Junta General lasnormas recogidas en la Ley de Sociedades de Capital, con las siguientes especialidades: 1. La Junta General ser谩 convocadamediante comunicaci贸n individual y escrita - correo certificado, burofax o "Art.15.bis. Consejo telem谩tico. Se admite expresamente lacelebraci贸n de reuni贸n del Consejo de Administraci贸n mediante sistemas de telecomunicaci贸n siempre que los asistentes puedan serdebidamente identificados y puedan ejercer sus derechos de informaci贸n y voto. En este caso, la sesi贸n del. Datos registrales. T4462 , F 90, S 8, H Z 50980, I/A 24 ( 5.08.22).

14 de Julio de 2020
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4327 , F193, S 8, H Z 50980, I/A 20 ( 7.07.20).

11 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LAS MORENAS MONEO ENRIQUE. Presidente: DE LAS MORENAS MONEO ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: WHITE MARTIN RAMON. Presidente: WHITE MARTIN RAMON. Datos registrales. T 4327 , F 193, S8, H Z 50980, I/A 18 ( 4.06.19).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4327 , F 193, S 8, H Z 50980, I/A 19 ( 4.06.19).

21 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: REDONDO SANCHEZ JESUS ARSENIO;GRANERO ESCUDERO ANABEL;CALVO MARINNATALIA;PI脩ERO GUERRERO JUAN ANTONIO;SANCHEZ MARTIN ANA. Datos registrales. T 4327 , F 190, S 8, H Z 50980, I/A 15(13.05.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLEGO RAMOS PAULA. Datos registrales. T 4327 , F 190, S 8, H Z 50980, I/A 16 (13.05.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAPUOZZO LUCA. Datos registrales. T 4327 , F 192, S 8, H Z 50980, I/A 17 (13.05.19).

27 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: OSCA GIMENO JORGE;PEREZ FRANCES FRANCISCO JAVIER;WHITE MARTIN RAMON. Datosregistrales. T 4327 , F 188, S 8, H Z 50980, I/A 13 (21.06.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: WHITE MARTIN RAMON. Datos registrales. T 4327 , F 189, S 8, H Z 50980, I/A 14 (21.06.18).

28 de Marzo de 2018
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BANCALE SERVICIOS INTEGRALES SL.Nombramientos. SecreNoConsj: PACHECO PLAZA TERESA. Consejero: DE LAS MORENAS MONEO ENRIQUE. Presidente: DELAS MORENAS MONEO ENRIQUE. Consejero: GRACIA TRULLENQUE JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL;OSCAGIMENO JORGE;SANCHEZ ARANDA LOURDES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR JOAQUIN AZNAR MOLINA 2 (ZARAGOZA). Datosregistrales. T 3815 , F 13, S 8, H Z 50980, I/A 4 (21.03.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: GRACIA TRULLENQUE JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3815 , F 13,S 8, H Z 50980, I/A 5 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: MAGLIOCCO NICHOLAS. Datos registrales. T 3815 , F 13, S 8, H Z 50980, I/A 6 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA NOMBELA ADOLFO. Datos registrales. T 3815 , F 14, S 8, H Z 50980, I/A 7 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROBLES GARCIA MARIA EMMA;GARCIA CATTANEO GONZALO;ALVAREZ OREJASGUILLERMO;PRADO VILLANUEVA MIGUEL;LOPEZ FERNANDEZ IVAN;RODRIGUEZ VIDAL ANTONIO MARIO. Datos registrales.T 3815 , F 15, S 8, H Z 50980, I/A 8 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN GIL ELENA;AREVALO BARJOLA CARLOS. Datos registrales. T 3815 , F 16, S 8, H Z50980, I/A 9 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA CATTANEO GONZALO;PRADO VILLANUEVA MIGUEL;LOPEZ FERNANDEZ IVAN;RIQUELMEBROTONS ANTONIO;LOPEZ DE VILLALTA Y PEINADO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4327 , F 186, S 8, H Z 50980,I/A 10 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: PEREA SUAREZ DE URBINA SARA;OSCA GIMENO JORGE. Datos registrales. T 4327 , F 186, S 8, HZ 50980, I/A 11 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERENGUER GOMEZ VIRGINIA;FERNANDEZ SANCHEZ ELENA;REILLO ALFONSOOLGA;PACHECO PLAZA TERESA;RIQUELME BROTONS ANTONIO;LOPEZ DE VILLALTA Y PEINADO FRANCISCO JAVIER;DEMENA PERNIL PABLO. Datos registrales. T 4327 , F 187, S 8, H Z 50980, I/A 12 (21.03.18).

25 de Julio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: GRACIA TRULLENQUE JORGE;ALFONSO VAZQUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3815 , F10, S 8, H Z 50980, I/A 3 (18.07.17).

30 de Marzo de 2016
Cambio de domicilio social. PLAZA SALAMERO 14 ENTR. C (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3815 , F 10, S 8, H Z 50980, I/A 2(17.03.16).

29 de Diciembre de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.12.10. Objeto social: a) el estudio, implementaci贸n y explotaci贸n de instalaciones deaprovechamiento a partir de la energ铆a e贸lica. b) la obtenci贸n y utilizaci贸n de derechos, concesiones, habilitaciones y autorizacionesadministrativas que sean necesarias para el desarrollo de las actividades descritas en el apartado a). Domicilio: C/ ALBAREDA 1B 2潞 B(ZARAGOZA). Capital: 3.010,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BANCALE SERVICIOS INTEGRALES SL.Nombramientos. Adm. Unico: BANCALE SERVICIOS INTEGRALES SL. Datos registrales. T 3815 , F 9, S 8, H Z 50980, I/A 1(16.12.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n