Buscador CIF Logo

Actos BORME Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Spain -madrid- Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Spain -madrid- Sl

Actos BORME Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Spain -madrid- Sl - B84372101

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Spain -madrid- Sl con CIF B84372101

馃敊 Perfil de Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Spain -madrid- Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Bouwfonds European Real Estate Parking Fund Spain -madrid- Sl

21 de Julio de 2023
Revocaciones. Apoderado: VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;VALCARCEL SANCHEZPAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;HERNANDEZ MOLEDOUS JOHANA MARLENE. Datos registrales. T 33861 , F 205, S 8, H M381130, I/A 21 (14.07.23).

01 de Agosto de 2022
Cambio de domicilio social. C/ PINAR 7, 1陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 33861 , F 204, S 8, H M 381130, I/A 20(22.07.22).

15 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Nombramientos. Adm. Mancom.:GOVERNANCE SERVICES MANAGEMENTCO (MADRID) SL. Representan: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION. Datos registrales.T 33861 , F 203, S 8, H M 381130, I/A 18 ( 8.01.20).

Nombramientos. Apoderado: CASTA脩O CASTRO CONCEPCION;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;MONREAL JORDEVICTOR;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;PASTRANA GOMEZ ELENA;PEREZ-PELLON VALENTIN-GAMAZO JULIA;PASTRANA GOMEZ ELENA;VALCARCEL SANCHEZ PAULA;ORTEGA SANCHEZ RUBEN;MONREAL JORDEVICTOR;ORVAY ARROYO MERCEDES;HERNANDEZ MOLEDOUS JOHANA MARLENE. Datos registrales. T 33861 , F 204, S 8, HM 381130, I/A 19 ( 8.01.20).

10 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GOMEZ DIEZ ISABEL. Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ DIEZ ISABEL. Datos registrales. T33861 , F 203, S 8, H M 381130, I/A 17 (30.12.19).

22 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: SCHNEIDER MICHAEL;ERTLE ANDREAS;DUFIEUX CAMILLE;LEU DIRK;AUGAGNEUR AUDEMARIE THERESE;BERBERICH CARINA;FUHLBRUGGE HAUKE;OLDENBURG BIRGIT;ZIRSCHNITZ MICHAEL;KONIGNICOLE;STELLING LINDA CLAUDIA;PREMKE-BULL HEIKO. Datos registrales. T 33861 , F 202, S 8, H M 381130, I/A 16(12.01.18).

07 de Diciembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Se a帽ade a los Estatutos Sociales el articulo 10 Bis. Derechos Reales sobre las participaciones. Datosregistrales. T 33861 , F 202, S 8, H M 381130, I/A 15 (28.11.17).

28 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MAGIELSE BASJE;POHLE THOMAS JOACHIM HERMANN. Revocaciones. Apo.Sol.: MOLINANAVARRO RAFAEL;PERUYERO BLANCO RODRIGO;JIMENEZ MARQUEZ DAVID. Apoderado: TMF MANAGEMENT SPAIN SL.Apo.Sol.: SUAREZ BARCIA LUCIA. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL.Nombramientos. Adm. Mancom.: MEYER JAN PHILIPP;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA. Datos registrales. T 33861 ,F 201, S 8, H M 381130, I/A 14 (21.09.17).

14 de Septiembre de 2017
Modificaciones estatutarias. 7. Acciones/Participaciones.-. 8. Acciones/Participaciones.-. 16. Organizaci贸n de la administraci贸n de lasociedad.-. Cambio de objeto social. La Sociedad tiene por objeto social: La actividades que supongan la adquisici贸n, enajenaci贸n,tenencia, gesti贸n, administraci贸n y explotaci贸n, a trav茅s del arrendamiento o de otro modo, de propiedades o sociedades que lasposean. Asimismo, podr谩 llevar a cabo actividades a cuenta del Fo. Datos registrales. T 33861 , F 200, S 8, H M 381130, I/A 13 (6.09.17).

12 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ DAFOS JOSE ANTONIO;BORRERO ZORITA LUIS;GARCIA OLIVAN PABLO;ABASCALCANOVAS CLOTILDE;LLANOS CAMARERO LAURA;NU脩O FERNANDEZ MONGE TERESA. Datos registrales. T 33861 , F 200, S8, H M 381130, I/A 12 ( 4.09.17).

22 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SCHNEIDER JOUKE;POHLE THOMA JOACHIM HERMANN;MADRID CORPORATEMANAGEMENT SL. Representan: GOMEZ DIEZ ISABEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: MAGIELSE BASJE;GOMEZ DIEZISABEL;POHLE THOMAS JOACHIM HERMANN. Modificaciones estatutarias. 15. Administraci贸n y Representacion.-. Datosregistrales. T 21430 , F 105, S 8, H M 381130, I/A 11 (13.10.15).

29 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CORDOBA FERNANDO EMILIANO. Revocaciones. Apo.Sol.: CORDOBA FERNANDOEMILIANO. Nombramientos. Adm. Mancom.: MADRID CORPORATE MANAGEMENT SL. Representan: GOMEZ DIEZ ISABEL.Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL. Datos registrales. T 21430 , F 104,S 8, H M 381130, I/A 10 (16.12.09).

04 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: BRAXTON TAX AND LAW SL. Datos registrales. T 21430 , F 104, S 8, H M 381130, I/A 9 (23.10.09).

10 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VAN SUSANTE JOHANNES LAMBERTUS MARIA;KLIJNEN JOHANNES LAURENT MARIAJOSEPH. Nombramientos. Adm. Mancom.: SCHNEIDER JOUKE;POHLE THOMA JOACHIM HERMANN;CORDOBA FERNANDOEMILIANO. Modificaciones estatutarias. 15. ADMINISTRADORES. Datos registrales. T 21430 , F 103, S 8, H M 381130, I/A 8

23 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: CORDOBA FERNANDO EMILIANO;GOMEZ DIEZ ISABEL;SUAREZ BARCIA LUCIA. Cambio dedomicilio social. C/ PINAR, 7 5潞 - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 21430 , F 103, S 8, H M 381130, I/A 7 (10.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n