Actos BORME de Brilen Tech Sa
13 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4541 , F 135, S 8, H Z 20973, I/A 47 ( 3.11.23).
10 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 4541 , F 135, S 8, H Z 20973, I/A 46 ( 2.11.23).
22 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: CEJALVO GORDO JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: CEJALVO GORDO JUANANTONIO. Datos registrales. T 4541 , F 134, S 8, H Z 20973, I/A 45 (14.03.23).
09 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL;VILLARIG TOMAS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 4541 , F 134,S 8, H Z 20973, I/A 44 ( 2.02.22).
20 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 4541 ,F 133, S 8, H Z 20973, I/A 42 (13.10.21).
Nombramientos. Consejero: LUENGO EGIDO JAVIER. Presidente: LUENGO EGIDO JAVIER. Cons.Del.Sol: LUENGO EGIDOJAVIER. Reelecciones. Vicepresid.: ORERA PE脩A JOSE RUBEN. Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Otros conceptos:Cambiado el representante del consejero SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Datos registrales. T 4541 , F 133, S 8, H Z 20973,I/A 43 (13.10.21).
09 de Agosto de 2021Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4541 , F 133, S 8, H Z20973, I/A 41 ( 2.08.21).
27 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: MIRANDA SIMAVILLA JUAN. Datos registrales. T 3541 , F 51, S 8, H Z 20973, I/A 40 (20.07.21).
07 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: ORERA PE脩A JOSERUBEN. Vicepresid.: ORERA PE脩A JOSE RUBEN. Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Secretario: FRAJ GASCONMIGUEL ANGEL. Consejero: SOCIEDAD ANONIMA MINERA CATALANO ARAGONESA. Cons.Del.Sol: ORERA PE脩A JOSERUBEN;FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3541 , F 51, S 8, H Z 20973, I/A 38 (30.06.21).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 3541 , F 51, S 8, H Z 20973, I/A 39 (30.06.21).
04 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: RAMOS MU脩OZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3541 , F 50, S 8, H Z 20973, I/A 37 (27.12.18).
16 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: RAMOS MU脩OZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3541 , F 49, S 8, H Z 20973, I/A 36 ( 8.11.18).
05 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 3541 , F 49, S 8, H Z20973, I/A 35 (28.09.18).
07 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 3541 , F 49, S 8, H Z20973, I/A 34 (29.12.15).
25 de Agosto de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL;FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL;ORERAPE脩A JOSE RUBEN. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Vicepresid.: ORERA PE脩A JOSE RUBEN. Cons.Del.Sol: ORERAPE脩A JOSE RUBEN. Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL.Nombramientos. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: ORERA PE脩AJOSE RUBEN. Vicepresid.: ORERA PE脩A JOSE RUBEN. Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Secretario: FRAJ GASCONMIGUEL ANGEL. Consejero: SA MINERA CATALANO ARAGONESA. Cons.Del.Sol: ORERA PE脩A JOSE RUBEN;FRAJ GASCONMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3541 , F 48, S 8, H Z 20973, I/A 32 (17.08.15).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 22潞.- El cargo de consejero es gratuito.. Datos registrales. T 3541 , F 49, S 8, H Z 20973, I/A33 (17.08.15).
05 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: BARRABES CASTANERA FRANCISCO. Datos registrales. T 3541 , F 48, S 8, H Z 20973, I/A 31(27.04.15).
18 de Julio de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BRILEN SA. Datos registrales. T 3541 , F 48, S 8, H Z 20973, I/A 30 ( 9.07.14).
03 de Febrero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Desembolsado: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.600.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.600.000,00 Euros. Datos registrales. T 3541 , F 48, S 8, H Z 20973, I/A 29 (27.01.14).
25 de Septiembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.401.001,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.071,50 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 71,50 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.500.000,00 Euros.Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.600.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.600.000,00 Euros. Datosregistrales. T 3541 , F 47, S 8, H Z 20973, I/A 28 (16.09.13).
22 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ PUEYO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2959 , F 49, S 8, H Z 20973, I/A 26(14.05.13).