Actos BORME de Burgos Club De Futbol Sad
01 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: BNFIX KLZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 794, L 585, F 151, S 8, H BU 17409, I/A 17 (25.11.22).
07 de Septiembre de 2022Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: YUCON BUSINESS SL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.982.549,50 Euros.Resultante Suscrito: 5.964.206,00 Euros. Datos registrales. T 794, L 585, F 151, S 8, H BU 17409, I/A 16 ( 1.09.22).
09 de Junio de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.819.950,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:2.981.656,50 Euros. Resultante Suscrito: 2.981.656,50 Euros. Datos registrales. T 746, L 537, F 26, S 8, H BU 17409, I/A 15 (3.06.22).
10 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA GARROTE DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: VELAZQUEZ GONZALEZDIEGO. Datos registrales. T 746, L 537, F 26, S 8, H BU 17409, I/A 14 ( 4.03.22).
15 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CASELLI FRANCO ANTONIO;SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO;ALONSO GARCIA JULIANALFONSO;CASELLI BRUNO;CASSINA FERNANDO;ALTEMIR FRANCISCO;DIAZ DIEGO DANIEL. Presidente: CASELLI FRANCOANTONIO. Vicepresid.: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Cons.Del.Sol: CASELLI FRANCO ANTONIO;CASSINA FERNANDO.Nombramientos. Apo.Sol.: SANTIDRIAN HIDALGO RODRIGO. Consejero: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO;SANTIDRIANHIDALGO RODRIGO;BENAVENTE DE CASTRO MIGUEL ANGEL;ALONSO GARCIA JULIAN ALFONSO;MARTINEZ NOGAL JESUS.Presidente: SANTIDRIAN HIDALGO RODRIGO. Vicepresid.: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Apo.Sol.: SAN MILLANVALDIVIELSO IGNACIO;BENAVENTE DE CASTRO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 746, L 537, F 25, S 8, H BU 17409, I/A 13( 8.10.21).
04 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MANZANEDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 746, L 537, F 24, S 8, H BU 17409,I/A 12 (29.01.21).
06 de Noviembre de 2020Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ MANZANEDO JOSE LUIS. Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.070.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 3.819.950,00 Euros. Datos registrales. T 746, L 537, F 23, S 8, H BU 17409, I/A 11 (30.10.20).
29 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO;ALONSO GARCIA JULIAN ALFONSO;BENAVENTE DECASTRO MIGUEL ANGEL;SANTIDRIAN HIDALGO RODRIGO. Secretario: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Vicepresid.: SANMILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Consejero: MARTINEZ NOGAL JESUS. Presidente: MARTINEZ NOGAL JESUS. Revocaciones.Apo.Sol.: MARTINEZ NOGAL JESUS;SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA GARROTEDAVID. Consejero: CASELLI FRANCO ANTONIO;SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO;ALONSO GARCIA JULIANALFONSO;CASELLI BRUNO;CASSINA FERNANDO;ALTEMIR FRANCISCO;DIAZ DIEGO DANIEL. Presidente: CASELLI FRANCOANTONIO. Vicepresid.: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Cons.Del.Sol: CASELLI FRANCO ANTONIO;CASSINA FERNANDO.Datos registrales. T 746, L 537, F 22, S 8, H BU 17409, I/A 10 (23.01.20).
Nombramientos. Auditor: BNFIX KLZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 746, L 537, F 22, S 8, H BU 17409, I/A 9 (23.01.20).
15 de Julio de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 749.950,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.749.950,00 Euros. Datos registrales. T 746, L 537, F 19, S8, H BU 17409, I/A 8 ( 9.07.19).
10 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTON SAN JUAN GONZALO. Datos registrales. T 746, L 537, F 19, S 8, H BU 17409, I/A 7 (4.04.19).
05 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS. Presidente: GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS. Nombramientos.Consejero: MARTINEZ NOGAL JESUS. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.burgoscf.es.Datos registrales. T 746, L 537, F 17, S 8, H BU 17409, I/A 4 (27.02.19).
Revocaciones. Apoderado: PASCUAL AMORROSTA MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO;PASCUALAMORROSTA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Presidente: MARTINEZ NOGAL JESUS. Apo.Sol.: MARTINEZ NOGALJESUS;SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Apoderado: CABEZA AYALA I脩IGO. Datos registrales. T 746, L 537, F 18, S 8, H BU17409, I/A 5 (27.02.19).
Nombramientos. Auditor: BNFIX KLZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 746, L 537, F 19, S 8, H BU 17409, I/A 6 (27.02.19).
10 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: PASCUAL AMORROSTA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 746, L 537, F 17, S 8, H BU 17409,I/A 2 ( 4.07.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO;PASCUAL AMORROSTA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T746, L 537, F 17, S 8, H BU 17409, I/A 3 ( 4.07.18).
10 de Mayo de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.02.18. Objeto social: Participaci贸n en competiciones deportivas oficiales de F煤tbol.Promoci贸n y desarrollo de actividades deportivas y de otras relacionadas, como publicidad, marketing, marcas, espect谩culos.Adquisici贸n y explotaci贸n de inmuebles, de acciones, obligaciones y participaciones en otras sociedades. Domicilio: C/ DOS DE MAYOS/N (BURGOS). Capital: 1.000.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS;SAN MILLANVALDIVIELSO IGNACIO;ALONSO GARCIA JULIAN ALFONSO;ANTON SAN JUAN GONZALO;BENAVENTE DE CASTRO MIGUELANGEL;SANTIDRIAN HIDALGO RODRIGO. Presidente: GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS. Secretario: SAN MILLAN VALDIVIELSOIGNACIO. Vicepresid.: SAN MILLAN VALDIVIELSO IGNACIO. Otros conceptos: CONSTITUCION de la Sociedad An贸nimaDeportiva "BURGOS CLUB DE FUTBOL" por TRANSFORMACION del "BURGOS CLUB DE FUTBOL". Datos registrales. T 746, L537, F 1, S 8, H BU 17409, I/A 1 ( 3.05.18).