Buscador CIF Logo

Actos BORME Burgospetrol Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Burgospetrol Sl

Actos BORME Burgospetrol Sl - B09254251

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Burgospetrol Sl con CIF B09254251

馃敊 Perfil de Burgospetrol Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Burgospetrol Sl

11 de Diciembre de 2014
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 671, L 462, F 52, S 8, H BU 1284, I/A 28 ( 3.12.14).

27 de Octubre de 2014
Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE LA HOJA REGISTRAL DE "BURGOSPETROL SL",ABSORBIDA JUNTO CON OTRA POR "CEPSA COMERCIAL NOROESTE SL (Registro de MADRID), DE CONFORMIDAD CON ELART. 231 REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. Datos registrales. T 671, L 462, F 52, S 8, H BU 1284, I/A nota (21.10.14).

25 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Presidente: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Revocaciones.Apo.Man.Soli: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Nombramientos. Consejero: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Apo.Man.Soli:GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Presidente: GRANDA CAMPO JUAN RAMON. Apo.Manc.: SANCHEZ BOTRAN JACINTO;MARINMORAN JUAN LUIS;RUIZ GUTIERREZ JAIME;MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 582, L 373, F 144, S 8, H BU 1284, I/A25 (18.11.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FREIRE LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Dir. General: FREIRE LOPEZ FRANCISCO JAVIER.Apo.Manc.: GRANDA CAMPO JUAN RAMON;MARIN MORAN JUAN LUIS;RUIZ GUTIERREZ JAIME;SAENZ MU脩OZGONZALO;SANCHEZ BOTRAN JACINTO;MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 671, L 462, F 43, S 8, H BU 1284, I/A 26(18.11.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESTEBAN FERREIRO MARTA. Apo.Manc.: FREIRE LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 671, L 462, F 50, S 8, H BU 1284, I/A 27 (18.11.13).

22 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 582, L 373, F 143, S 8, H BU 1284, I/A 22 (15.10.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL SANMARTIN JAVIER;RIBER GIL FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: SANZHERNANDEZ LUIS-FERNANDO. Datos registrales. T 582, L 373, F 143, S 8, H BU 1284, I/A 23 (15.10.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANDINO PEREZ JAVIER;SANDINO ESTEBAN DIEGO. Nombramientos. Consejero: HERRAN DELENIZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 582, L 373, F 144, S 8, H BU 1284, I/A 24 (15.10.13).

24 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: GIL SANMARTIN JAVIER. Datos registrales. T 582, L 373, F 143, S 8, H BU 1284, I/A 21(18.06.13).

14 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: SANCHEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN. Vicesecret.: VELASCO DIAZ MARIA LUISA.Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ ALMARAZ LUCIA ENCARNACION. VsecrNoConsj: GONZALEZ SAENZ EMILIOJESUS. Datos registrales. T 582, L 373, F 142, S 8, H BU 1284, I/A 19 ( 7.05.13).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANDINO GONZALEZ SANTIAGO. Datos registrales. T 582, L 373, F 143, S 8, H BU 1284, I/A 20 (7.05.13).

29 de Noviembre de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCALDE LOPEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SEBASTIAN BERRENDERO JUANANTONIO. Apo.Manc.: MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 582, L 373, F 142, S 8, H BU 1284, I/A 18 (20.11.12).

06 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Presidente: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Revocaciones.Apo.Man.Soli: PEREZ ROMERA JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Apo.Man.Soli:PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Presidente: PEREZ HERNANDEZ FLORENCIO. Apo.Man.Soli: MARIN MORAN JUAN LUIS;GILSAN MARTIN FRANCISCO JAVIER;MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 582, L 373, F 139, S 8, H BU 1284, I/A 17(26.07.12).

16 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: COBOS MOLINA FEDERICO. Datos registrales. T 582, L 373, F 138, S 8, H BU 1284, I/A 16 (4.11.10).

27 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCALDE LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 582, L 373, F 138, S 8, H BU 1284, I/A 15(18.08.10).

20 de Julio de 2010
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 582, L 373, F 138, S 8, H BU 1284, I/A 14 ( 9.07.10).

09 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MORAN MOYA CARLOS. Datos registrales. T 582, L 373, F 136, S 8, H BU 1284, I/A 13 ( 1.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n