Buscador CIF Logo

Actos BORME Bussines Center Manzanares Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Bussines Center Manzanares Sl

Actos BORME Bussines Center Manzanares Sl - B85366573

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Bussines Center Manzanares Sl con CIF B85366573

馃敊 Perfil de Bussines Center Manzanares Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Bussines Center Manzanares Sl

18 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: RIBEIRO BASTOS JOAO FILIPE;BORGES HUGO MIGUEL BERNARDINO;FREIRE DE OLIVEIRAPAULO ALEXANDRE MELES SALDANHA;HERNANDEZ SANCHEZ LUIS. Datos registrales. T 45393 , F 155, S 8, H M 457507, I/A27 (11.12.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 45393 ,F 156, S 8, H M 457507, I/A 28 (11.12.23).

13 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Presidente: COUTOALVES MANUEL ANTONIO. Con.Delegado: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO. Secretario: SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO.Nombramientos. Consejero: BORGES HUGO MIGUEL BERNARDINO;HERNANDEZ SANCHEZ LUIS;FREIRE DE OLIVEIRAPAULO ALEXANDRE MELES SALDANHA. Presidente: BORGES HUGO MIGUEL BERNARDINO. Secretario: HERNANDEZSANCHEZ LUIS. Cons.Del.Man: BORGES HUGO MIGUEL BERNARDINO;RIBEIRO BASTOS JOAO FILIPE;FREIRE DE OLIVEIRAPAULO ALEXANDRE MELES SALDANHA;HERNANDEZ SANCHEZ LUIS. Datos registrales. T 25400 , F 219, S 8, H M 457507, I/A26 ( 3.11.23).

21 de Junio de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 25400 , F219, S 8, H M 457507, I/A 25 (14.06.23).

01 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL.Datos registrales. T 25400 , F 218, S 8, H M 457507, I/A 24 (22.02.22).

15 de Octubre de 2020
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25400 , F 218, S 8, H M 457507,I/A 23 ( 7.10.20).

05 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;MOUTINHO MARTINS PAULO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO.Datos registrales. T 25400 , F 218, S 8, H M 457507, I/A 22 (27.04.20).

22 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 25400 , F 218, S 8, H M 457507, I/A21 (15.10.19).

18 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 25400, F 217, S 8, H M 457507, I/A 20 (11.02.19).

01 de Febrero de 2019
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 18陋 AL REELECCION DE SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSOCOMO SECRETARIO NO CONSEJERO, SIENDO LO CORRECTO EL CESE DEL MISMO Y SU NOMBRAMIENTO COMOSECRETARIO DEL CONSEJO. Datos registrales. T 25400 , F 216, S 8, H M 457507, I/A 18 ( 3.12.18).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Nombramientos. Secretario: SANZ DE SANTOS JUANALFONSO. Datos registrales. T 25400 , F 216, S 8, H M 457507, I/A 18 ( 3.12.18).

16 de Enero de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;MOUTINHO MARTINS PAULO;SANZ DE SANTOS JUANALFONSO;MOUTINHO MARTINS PAULO. Datos registrales. T 25400 , F 216, S 8, H M 457507, I/A 19 ( 8.01.19).

11 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOUTINHO MARTINS PAULO. Nombramientos. Consejero: SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO.Reelecciones. SecreNoConsj: SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Presidente: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO.Con.Delegado: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 25400 , F 216, S 8, H M 457507, I/A 18 ( 3.12.18).

15 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: FIUZA GOMES CONCALVES ANTUNES CANDIDO;DE OLIVEIRA REIS JOAQUIM JOSE;MOUTINHOMARTINS PAULO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 25400 , F 147, S 8, H M 457507, I/A 17 ( 4.10.18).

09 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;MOUTINHO MARTINS PAULO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO.Datos registrales. T 25400 , F 147, S 8, H M 457507, I/A 16 ( 1.02.18).

21 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;MOUTINHO MARTINS PAULO;SANZ DE SANTOS JUANALFONSO;MOUTINHO MARTINS PAULO. Datos registrales. T 25400 , F 146, S 8, H M 457507, I/A 15 ( 9.08.17).

28 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE OLIVEIRA REIS JOAQUIM JOSE;FIUZA GOMES CONCALVES ANTUNES CANDIDO.Nombramientos. Consejero: BASTOS JOAO FILIPE RIBEIRO;MOUTINHO MARTINS PAULO. Reelecciones. SecreNoConsj:SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Presidente: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO. Con.Delegado: COUTO ALVES MANUELANTONIO. Datos registrales. T 25400 , F 146, S 8, H M 457507, I/A 14 (18.07.17).

08 de Julio de 2016
Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 25400 , F 145, S8, H M 457507, I/A 13 (30.06.16).

01 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 25400 , F 144, S 8, H M 457507, I/A 12(22.06.16).

18 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: FIUZA GOMES CONCALVES ANTUNES CANDIDO;DE OLIVEIRA REIS JOAQUIM JOSE. Datosregistrales. T 25400 , F 143, S 8, H M 457507, I/A 9 ( 9.03.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: MOUTINHO MARTINS PAULO;SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 25400 , F144, S 8, H M 457507, I/A 10 ( 9.03.16).

Cambio de domicilio social. C/ MADRID 14 1& B Y C (GETAFE). Datos registrales. T 25400 , F 144, S 8, H M 457507, I/A 11(11.03.16).

19 de Febrero de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 349,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.694,00 Euros. Datos registrales. T 25400 , F 143, S8, H M 457507, I/A 8 (12.02.16).

05 de Febrero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.943,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.043,00 Euros. Datos registrales. T 25400 , F 140, S 8, H M457507, I/A 6 (28.01.15).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO. Nombramientos. Con.Delegado: COUTO ALVESMANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 25400 , F 142, S 8, H M 457507, I/A 7 (29.01.15).

04 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Presidente: RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Cons.Del.Man:RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Consejero: GONZALEZ VILA JOAQUIN. Secretario: GONZALEZ VILA JOAQUIN. Cons.Del.Man:GONZALEZ VILA JOAQUIN. Consejero: MALHEIRO VIAMONTE FIGUEIRA DE SOUSA JOSE EDUARDO. Cons.Del.Man:MALHEIRO VIAMONTE FIGUEIRA DE SOUSA JOSE EDUARDO. Consejero: RODRIGUEZ OGANDO MARCOS. Cons.Del.Man:RODRIGUEZ OGANDO MARCOS. Consejero: BRITO DOS SANTOS FERNANDO CARLOS. Cons.Del.Man: BRITO DOS SANTOSFERNANDO CARLOS. Vicepresid.: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO. Nombramientos. Consejero: DE OLIVEIRA REISJOAQUIM JOSE;FIUZA GOMES CONCALVES ANTUNES CANDIDO. Presidente: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO.SecreNoConsj: SANZ DE SANTOS JUAN ALFONSO. Cambio de domicilio social. C/ RICARDO DE LA VEGA, 3-01-02B(GETAFE). Datos registrales. T 25400 , F 140, S 8, H M 457507, I/A 5 (28.01.15).

23 de Septiembre de 2013
Otros conceptos: Subsanaci贸n del domicilio social siendo el correcto: Madrid,Avenida del Manzanares n煤mero 204. Datosregistrales. T 25400 , F 139, S 8, H M 457507, I/A 4 (11.09.13).

15 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: RODRIGUEZ OGANDO MARCOS;MALHEIRO VIAMONTE FIGUEIRA DE SOUSA JOSEEDUARDO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Presidente: RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Cons.Del.Man:RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE. Consejero: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO. Vicepresid.: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO.Cons.Del.Man: COUTO ALVES MANUEL ANTONIO. Consejero: GONZALEZ VILA JOAQUIN. Secretario: GONZALEZ VILA JOAQUIN.Cons.Del.Man: GONZALEZ VILA JOAQUIN. Consejero: MALHEIRO VIAMONTE FIGUEIRA DE SOUSA JOSE EDUARDO.Cons.Del.Man: MALHEIRO VIAMONTE FIGUEIRA DE SOUSA JOSE EDUARDO. Consejero: RODRIGUEZ OGANDO MARCOS.Cons.Del.Man: RODRIGUEZ OGANDO MARCOS. Consejero: BRITO DOS SANTOS FERNANDO CARLOS. Cons.Del.Man: BRITODOS SANTOS FERNANDO CARLOS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoresmancomunados a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 25400 , F 138, S 8, H M 457507, I/A 3 (30.05.09).

12 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INVES GENCIBIO SL. Representan: MARCHINI BRAVO JUAN LUIS. Nombramientos. Adm.Mancom.: RODRIGUEZ OGANDO MARCOS;MALHEIRO VIAMONTE FIGUEIRA DE SOUSA JOSE EDUARDO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambio de objetosocial. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PERFORACIONES, DESMONTES Y VACIADOS, EXPLANACIONES, CANTERAS, POZOS YGALERIAS, TUNELES, PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS, DE FABRICA Y HORMIGON EN MASA, ARMADO,PRENSADO, METALICOS..... Datos registrales. T 25400 , F 137, S 8, H M 457507, I/A 2 (30.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n