Buscador CIF Logo

Actos BORME Cable Television Albacete Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cable Television Albacete Sociedad Limitada

Actos BORME Cable Television Albacete Sociedad Limitada - B02151819

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Cable Television Albacete Sociedad Limitada con CIF B02151819

🔙 Perfil de Cable Television Albacete Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Cable Television Albacete Sociedad Limitada

31 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1016, L 780, F 145, S 8, H AB 1228, I/A 34(24.12.21).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 1016, L 780, F 145, S 8, H AB 1228, I/A 35(24.12.21).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 1016, L 780, F 145, S 8, H AB 1228, I/A 36(24.12.21).

Nombramientos. Apoderado: CORCOLES JAQUERO ELOY. Datos registrales. T 1040, L 804, F 36, S 8, H AB 1228, I/A 37(24.12.21).

02 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: CIFUENTES OVEJERO JUAN MACARIO. Datos registrales. T 945, L 709, F 92, S 8, H AB 1228, I/A 32

Nombramientos. Apoderado: MORENO SANCHEZ ANTONIO. Datos registrales. T 945, L 709, F 92, S 8, H AB 1228, I/A 33(24.02.20).

03 de Julio de 2015
Reducción de capital. Importe reducción: 240.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliación de capital. Capital:10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000,00 Euros. Datos registrales. T 945, L 709, F 92, S 8, H AB 1228, I/A 31 (29.06.15).

04 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ PERETE FEDERICO. Datos registrales. T 930, L 694, F 29, S 8, H AB 1228, I/A 30(30.06.14).

08 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: CIFUENTES OVEJERO JUAN MACARIO. Datos registrales. T 927, L 691, F 203, S 8, H AB 1228, I/A28 ( 1.04.13).

Nombramientos. Apoderado: CANUTO CHINCHILLA PEDRO JAVIER. Datos registrales. T 927, L 691, F 203, S 8, H AB 1228, I/A29 ( 1.04.13).

06 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apoderado: VELASCO JIMENEZ CARLOS. Datos registrales. T 927, L 691, F 94, S 8, H AB 1228, I/A 27 (30.01.13).

22 de Enero de 2013
Nombramientos. Apoderado: ALARCON TAUSTE JESUS. Datos registrales. T 927, L 691, F 94, S 8, H AB 1228, I/A 26 (15.01.13).

11 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;SANCHEZ HERRAEZ ADORACION;MARTINEZ SANCHEZCONSUELO;MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL;MARTINEZ SANCHEZ NOELIA MARIA. Secretario: MARTINEZ SANCHEZCONSUELO. Vicepresid.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Con.Delegado:MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: CORPORACION HMS HERMASAN SOCIEDAD LIMITADA.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9.2.1. La convocatoria de la Junta General de a Sociedad ser hará mediante =óANUNCIOEN LA PAGINA WEB DE LA MISMAº=, obligándose los administradores a mantenerlo insertado en la página web durante el términoexigido por la Ley. Con carácter voluntario y adicional se podrá realizar también Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.visionseis.tv. Datosregistrales. T 903, L 667, F 9, S 8, H AB 1228, I/A 25 ( 2.10.12).

26 de Enero de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 899, L 663, F 118, S 8, H AB 1228, I/A24 (17.01.11).

27 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Datos registrales. T 881, L 645, F 34, S 8, H AB 1228, I/A 23(17.09.10).

11 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: SANCHEZ HERRAEZ ADORACION. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ SANCHEZ NOELIAMARIA. Secretario: MARTINEZ SANCHEZ CONSUELO. Vicepresid.: MARTINEZ SANCHEZ JOSE MANUEL. Reelecciones.Presidente: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Con.Delegado: MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T881, L 645, F 34, S 8, H AB 1228, I/A 22 ( 2.08.10).

03 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MARTINEZ GINES. Datos registrales. T 881, L 645, F 34, S 8, H AB 1228, I/A 21 (25.05.09).

17 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MURCIA JESUS MARIA. Datos registrales. T 881, L 645, F 34, S 8, H AB 1228, I/A 20 (6.02.09).

16 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: VELASCO JIMENEZ CARLOS. Datos registrales. T 855, L 619, F 163, S 8, H AB 1228, I/A 19 (6.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información