Actos BORME de Cadbe Sl
28 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LM NORSU SL. Representan: GRANDA LOPEZ LUIS MANUEL. Nombramientos.SecreNoConsj: FERNANDEZ HERRERO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 38223 , F 202, S 8, H M 421281, I/A 16 (18.12.20).
12 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: DE BENITO GONZALEZ PATRICIA. Datos registrales. T 38223 , F 202, S 8, H M 421281, I/A 14 (5.03.20).
Nombramientos. Apo.Manc.: FELIX PASOS MARTINEZ;DE BENITO GONZALEZ PATRICIA. Datos registrales. T 38223 , F 202, S8, H M 421281, I/A 15 ( 5.03.20).
19 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 38223 , F 201, S 8, H M421281, I/A 12 (12.03.19).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PASOS MARTINEZ FELIX. Nombramientos. SecreNoConsj: LM NORSU SL. Representan:GRANDA LOPEZ LUIS MANUEL. Datos registrales. T 38223 , F 201, S 8, H M 421281, I/A 13 (12.03.19).
22 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BENITO PEREZ CARLOS;GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN. Nombramientos.Consejero: DE BENITO PEREZ CARLOS;DE BENITO GONZALEZ PATRICIA;DE BENITO GONZALEZ DANIEL. Presidente: DEBENITO PEREZ CARLOS. Vicepresid.: DE BENITO GONZALEZ PATRICIA. Cons.Del.Sol: DE BENITO PEREZ CARLOS.SecreNoConsj: PASOS MARTINEZ FELIX. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 6.Las participaciones sociales. Art 7潞.- Art 22.-El cargo de Administrador ser谩 retribuido. Art 23 .-Consejo de Administraci贸n y creaci贸n deun nuevo art铆culo de los Estatutos con el n煤mero 28.- Separaci贸n de los Socios. Los art铆culos existentes de los. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 23482 , F 93, S 8, H M 421281, I/A 11(15.01.19).
20 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: PASOS MARTINEZ FELIX. Datos registrales. T 23482 , F 93, S 8, H M 421281, I/A 10 (13.03.18).
27 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: BENITO GONZALEZ PATRICIA. Datos registrales. T 23482 , F 92, S 8, H M 421281, I/A 9 (17.11.17).
01 de Octubre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 17.116,82 Euros. Resultante Suscrito: 226.293,08 Euros. Datos registrales. T 23482 , F87, S 8, H M 421281, I/A 8 (23.09.13).
07 de Junio de 2013Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BE & GO HOLDING SL. Datos registrales. T 23482 , F 87, S 8, H M 421281, I/A 7(31.05.13).
26 de Noviembre de 2009Modificaciones estatutarias. 22. Administraci贸n y Representacion.- RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. Datosregistrales. T 23482 , F 87, S 8, H M 421281, I/A 6 (17.11.09).
25 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: DE BENITO GONZALEZ ALVARO;BENITO GONZALEZ PATRICIA;DE BENITO GONZALEZ ALVARO.Datos registrales. T 23482 , F 85, S 8, H M 421281, I/A 4 (13.11.09).
Nombramientos. Apoderado: DE BENITO GONZALEZ ALVARO;DE BENITO GONZALEZ PATRICIA. Datos registrales. T 23482 , F86, S 8, H M 421281, I/A 5 (13.11.09).