Actos BORME de Caixabank Equipment Finance Sa
29 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MONTBLANCH GRIERA DAVID. Datos registrales. T 36579 , F 52, S 8, H M 656663, I/A 38(21.12.23).
26 de Octubre de 2023Revocaciones. Apoderado: OLIVARES GALERA JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 36579 , F 52, S 8, H M 656663, I/A 37(19.10.23).
01 de Junio de 2023Otros conceptos: Subsanación de la inscripción 33ª, en cuanto al segundo apellido del apoderado designado, siendo el nombre yapellidos correctos "Oscar Sánchez Jiménez". Datos registrales. T 36579 , F 49, S 8, H M 656663, I/A 34 (25.05.23).
26 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ JIMENEZ OSCAR. Datos registrales. T 36579 , F 48, S 8, H M 656663, I/A 33 (19.05.23).
20 de Abril de 2023Revocaciones. Apoderado: RETTALI LLORENS LEILA. Datos registrales. T 36579 , F 47, S 8, H M 656663, I/A 32 (13.04.23).
02 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: RETTALI LLORENS LEILA. Nombramientos. Apoderado: RETTALI LLORENS LEILA. Datos registrales.T 36579 , F 46, S 8, H M 656663, I/A 31 (23.02.23).
27 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ DE LA TORRE JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE LA TORREJOSE MANUEL. Datos registrales. T 36579 , F 44, S 8, H M 656663, I/A 30 (20.01.23).
25 de Agosto de 2022Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y nacionalidad . Cambio de domicilio social. AVDA DEMANOTERAS 20 - EDIFICIO PARIS (MADRID). Datos registrales. T 36579 , F 43, S 8, H M 656663, I/A 29 (18.08.22).
01 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE LA TORRE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 36579 , F 42, S 8, H M 656663, I/A28 (22.07.22).
12 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: DIAZ ORTIZ PABLO. Datos registrales. T 36579 , F 41, S 8, H M 656663, I/A 27 ( 4.01.22).
08 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36579 , F 41, S 8, H M 656663, I/A26 ( 1.10.21).
11 de Agosto de 2021Reelecciones. Adm. Unico: CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER EFC EP SA. Representan: OMS VILLEGAS JAVIER. Datosregistrales. T 36579 , F 40, S 8, H M 656663, I/A 25 ( 4.08.21).
03 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: AGUSTI CASANOVAS XAVIER;AGUSTI CASANOVAS XAVIER. Datos registrales. T 36579 , F 40, S 8,H M 656663, I/A 24 (27.01.21).
28 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36579 , F 40, S 8, H M 656663, I/A23 (21.10.20).
25 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: OÑORBE FIOL JOSE LUIS. Apo.Sol.: OÑORBE FIOL JOSE LUIS. Datos registrales. T 36579 , F 40, S8, H M 656663, I/A 22 (18.06.20).
31 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: AYEN PEREZ JUAN;AYEN PEREZ JUAN. Datos registrales. T 36579 , F 37, S 8, H M 656663, I/A 20(24.03.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: HERVAS NOVES JAVIER. Apoderado: HERVAS NOVES JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: HERVASNOVES JAVIER. Datos registrales. T 36579 , F 38, S 8, H M 656663, I/A 21 (24.03.20).
09 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: PARRILLA ROS MANEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARRILLA ROS MANEL;NUÑEZ SALIDODAVID;RODRIGUEZ ALCAIDE ELISABETH. Datos registrales. T 36579 , F 34, S 8, H M 656663, I/A 18 ( 2.03.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PUJOL AMAT JAVIER;LAGARES PUIG LUIS. Datos registrales. T 36579 , F 35, S 8, H M 656663,I/A 19 ( 2.03.20).
19 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARRILLA ROS MANEL. Datos registrales. T 36579 , F 33, S 8, H M 656663, I/A 17 (12.12.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: AGUSTI FLEMATTI FERNANDO PABLO. Datos registrales. T 36579 , F 32, S 8, H M 656663, I/A 16(25.03.19).
11 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: PRESA SORIANO NADIA. Datos registrales. T 36579 , F 31, S 8, H M 656663, I/A 15 ( 4.02.19).
19 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: OLIVARES GALERA JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 36579 , F 30, S 8, H M 656663, I/A 14(12.11.18).
14 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: LLUHEN CABELLOS LAURA. Datos registrales. T 36579 , F 28, S 8, H M 656663, I/A 9 ( 6.11.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: GIMENO JURADO EVA. Datos registrales. T 36579 , F 28, S 8, H M 656663, I/A 10 ( 6.11.18).
Revocaciones. Apoderado: HERVAS NOVES JAVIER. Datos registrales. T 36579 , F 29, S 8, H M 656663, I/A 11 ( 6.11.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: HERVAS NOVES JAVIER. Datos registrales. T 36579 , F 29, S 8, H M 656663, I/A 12 ( 6.11.18).
Nombramientos. Apoderado: HERVAS NOVES JAVIER. Datos registrales. T 36579 , F 29, S 8, H M 656663, I/A 13 ( 6.11.18).
09 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: RETTALI LLORENS LEILA. Datos registrales. T 36579 , F 27, S 8, H M 656663, I/A 8 ( 2.08.18).
22 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: MARTIN RUIZ JAVIER. Nombramientos. Representan: OMS VILLEGAS JAVIER. Datosregistrales. T 36579 , F 27, S 8, H M 656663, I/A 7 (14.06.18).
21 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: OTEROS GALLINAT GONZALO. Datos registrales. T 36579 , F 27, S 8, H M 656663, I/A 6 (13.03.18).
19 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MELERO ESTEVE JUAN;DE XAMMAR MERINO MARIA DEL CARMEN;MONTORO REDONDOSUSANA. Datos registrales. T 36579 , F 26, S 8, H M 656663, I/A 5 (12.03.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: HERVAS NOVES JAVIER. Datos registrales. T 36579 , F 26, S 8, H M 656663, I/A 3 (26.02.18).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ PUIG MONTSERRAT. Datos registrales. T 36579 , F 26, S 8, H M 656663, I/A 4(26.02.18).
14 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ CALERUEGA 102 (MADRID). Datos registrales. T 36579 , F 26, S 8, H M 656663, I/A 2 ( 6.11.17).
06 de Septiembre de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44599 , F 118, S 8, H B10673, I/A 187 (29.08.17).
26 de Junio de 2017Revocaciones. APODERAD.SOL: HERVAS NOVES JAVIER. Datos registrales. T 44599 , F 117, S 8, H B 10673, I/A 184(16.06.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: HERVAS NOVES JAVIER. Datos registrales. T 44599 , F 117, S 8, H B 10673, I/A 185(16.06.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: OÑORBE FIOL JOSE LUIS. Datos registrales. T 44599 , F 118, S 8, H B 10673, I/A 186(16.06.17).
08 de Febrero de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: TIANA GUARDIOLA FERNANDO. Datos registrales. T 44599 , F 116, S 8, H B 10673, I/A 182(31.01.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: RODRIGUEZ CALZADO RICARDO. Datos registrales. T 44599 , F 117, S 8, H B 10673, I/A183 (31.01.17).
04 de Octubre de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: DE LA ROSA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN;RIBES RANCH ALBERT;RODRIGUEZCALZADO RICARDO Datos registrales. T 44599 , F 116, S 8, H B 10673, I/A 181 (23.09.16).
24 de Agosto de 2016Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44599 , F 116, S 8, H B10673, I/A 180 (16.08.16).
21 de Abril de 2016Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MOYA ROSALES ESTEVE. Datos registrales. T 44599 , F 113, S 8, H B 10673, I/A 179(13.04.16).
14 de Abril de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: HERVAS NOVES JAVIER. Datos registrales. T 44599 , F 113, S 8, H B 10673, I/A 178 (5.04.16).