Actos BORME de Caja Rural Catolico Agraria Coop. De Credito V
30 de Octubre de 2023Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORESSL. Datos registrales. T 1843, L 1403, F 124, S 8, H CS 2048, I/A 132 (23.10.23).
21 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ BOSQUET SONIA. Datosregistrales. T 1843, L 1403, F 124, S 8, H CS 2048, I/A 131 (14.03.23).
08 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: MONZO COLOMER MANUEL. Datos registrales. T 1843, L 1403, F 123, S 8, H CS 2048, I/A 129(31.03.22).
27 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: ESPINOSA MANZANET SONIA. Datos registrales. T 1843, L 1403, F 122, S 8, H CS 2048, I/A 128(21.01.22).
27 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 140, S 8, H CS 2048, I/A 127(20.08.21).
22 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: PISA LALANA ANGEL;RODRIGUEZ MIRAS MARIA LUISA;MORENO GARCIA ANA BELEN;ROSBERRUEZO MARIA DEL CARMEN;ROSELLO FRIAS VICTORIANO;ALONSO RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL;BOSCH MARTI ANAMARIA;MARTINEZ GRANADOS JOSE ANTONIO;POVEDA ESCRIVA CARLOS;ARANEGA MARTINEZ JOSE ENRIQUE;GONZALEZ
29 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CUBERTORER AYET MANUEL;TELLOLS BASELGA SILVIA;MESEGUER JORDA PASCUAL. Datosregistrales. T 1726, L 1287, F 140, S 8, H CS 2048, I/A 125 (18.03.21).
25 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FONT GARCIA MARIA PILAR. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 139, S 8, H CS 2048, I/A 123(18.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: TELLOLS BASELGA SILVIA. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 140, S 8, H CS 2048, I/A 124(18.03.21).
29 de Diciembre de 2020Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 41 E INTRODUCIDA LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA ENLOS ESTATUTOS SOCIALES DEBIDO A LA REDUCCION DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR.. Datosregistrales. T 1726, L 1287, F 138, S 8, H CS 2048, I/A 122 (18.12.20).
16 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES GASQUEZ EMILIO JOAQUIN. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 138, S 8, H CS 2048, I/A121 ( 9.12.20).
12 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR;CANDAU VILANOVA ANA MARIA;CORTESCORBATO ENRIQUE;HERRERO MOMPO MARIA REMEDIOS;REVERTER ANDREU ENRIC. Suplente: MARTINEZ TORRECILLAMANUEL. Vcp.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR. Sec.Cons.Rec: CANDAU VILANOVA ANA MARIA.Vcs.Cons.Rec: SANCHEZ BOSQUET SONIA. Nombramientos. Sec.Cons.Rec: SANCHEZ BOSQUET SONIA. Mie.Cons.Rec:REVERTER ANDREU ENRIC;PETIT ORTELLS ANA ROSARIO;BROCH ARNAU MARIA DOLORES;MARTINEZ TORRECILLAMANUEL. Suplente: BONET TORAN VANESA. Vcp.Cons.Rec: MARTINEZ TORRECILLA MANUEL. Vcs.Cons.Rec: REVERTERANDREU ENRIC. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 137, S 8, H CS 2048, I/A 120 ( 4.11.20).
27 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL.Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 137, S 8, H CS 2048, I/A 119 (19.02.20).
12 de Noviembre de 2019Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 31, 60, 61 Y 62 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DEBIDO A LAMODIFICACION DEL CONTRATO REGULADOR DEL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR.. Datos registrales. T 1726, L 1287, F136, S 8, H CS 2048, I/A 118 ( 4.11.19).
23 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 135, S 8, H CS2048, I/A 117 (13.08.19).
31 de Enero de 2019P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.grupocooperativocajamar.es/caixaruralvila-real/es/. Datosregistrales. T 1726, L 1287, F 135, S 8, H CS 2048, I/A 116 (21.01.19).
22 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL;ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE;VICIEDO COLONQUESMANUEL;RAMOS CHABRERA SANTIAGO;CANDAU RAMOS CELINA. Suplente: ROVIRA GARCIA AMELIA. Vcs.Cons.Rec:CANDAU VILANOVA ANA MARIA. Pre.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL. Sec.Cons.Rec: CANDAU RAMOS CELINA.Nombramientos. Sec.Cons.Rec: CANDAU VILANOVA ANA MARIA. Mie.Cons.Rec: PESUDO ARNAL JOSE PASCUAL;PORTALESLLOP ENRIC PASQUAL;ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE;MULET GARGALLO MARIA TERESA;SANCHEZ BOSQUET SONIA.Pre.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL. Vcs.Cons.Rec: SANCHEZ BOSQUET SONIA. Datos registrales. T 1726, L1287, F 135, S 8, H CS 2048, I/A 115 (14.11.18).
03 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 135, S 8, H CS2048, I/A 114 (24.07.18).
12 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL;CUBERTORER AYET MANUEL. Datos registrales. T 1726, L1287, F 134, S 8, H CS 2048, I/A 113 ( 2.03.18).
02 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: FERRER BLANCO VICENTE. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 133, S 8, H CS 2048, I/A 112(23.01.18).
22 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: USO HERRERO AIDA. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 133, S 8, H CS 2048, I/A 110 (12.01.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: MESEGUER JORDA PASCUAL. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 133, S 8, H CS 2048, I/A 111(12.01.18).
22 de Noviembre de 2017Modificaciones estatutarias. mod. art. 6. mod. art. 32. mod. art. 33. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 132, S 8, H CS 2048, I/A109 (13.11.17).
29 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 131, S 8, H CS2048, I/A 107 (23.06.17).
19 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: COLONQUES VILAR JUAN VICENTE;COLONQUES VILAR JUAN VICENTE;TORAN MONFERRERCARLOS JOSE;TORAN MONFERRER CARLOS JOSE;TORAN MONFERRER CARLOS JOSE. Apoderado: TORAN MONFERRERCARLOS JOSE. Apo.Sol.: TORAN MONFERRER CARLOS JOSE. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 131, S 8, H CS 2048, I/A 106( 9.05.17).
07 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Suplente: LLOP USO JOSE. Mie.Cons.Rec: BALAGUER MARMANEU JOSE;BATALLA LLORENS JUANBAUTISTA SALVADOR;HERRERO MOMPO MARIA REMEDIOS;CANDAU VILANOVA ANA MARIA;CORTES CORBATO ENRIQUE.Vcs.Cons.Rec: ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE. Mie.Cons.Rec: ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE;RUBERT NEBOT LLORENC.Suplente: GARRIDO HERRERO SAMUEL PASCUAL. Vcp.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR.Nombramientos. Mie.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR;ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE;HERREROMOMPO MARIA REMEDIOS;CANDAU VILANOVA ANA MARIA;CORTES CORBATO ENRIQUE;REVERTER ANDREU ENRIC.Suplente: ROVIRA GARCIA AMELIA;MARTINEZ TORRECILLA MANUEL. Vcp.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTASALVADOR. Datos registrales. T 1726, L 1287, F 130, S 8, H CS 2048, I/A 105 (29.03.17).
04 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: BARACOA HOLDINGS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. Datos registrales. T 1652, L 1214, F58, S 8, H CS 2048, I/A 104 (21.03.17).
06 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: FONT DE MORA SAINZ PABLO. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 58, S 8, H CS 2048, I/A 103(24.02.17).
07 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 57, S 8, H CS 2048, I/A101 (25.10.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL;ROSELLO FRIAS VICTORIANO;ROS BERRUEZOMARIA DEL CARMEN;MORENO GARCIA ANA BELEN;RODRIGUEZ MIRAS MARIA LUISA. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 57,S 8, H CS 2048, I/A 102 (25.10.16).
10 de Octubre de 2016Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n articulo 41. Inclusi贸n Disposici贸n Adicional Primera.. Otros conceptos: Inclusi贸nDisposicion Adicional Primera. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 56, S 8, H CS 2048, I/A 100 ( 3.10.16).
14 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 56, S 8, H CS 2048, I/A 99 ( 7.07.16).
05 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: SANCHO RUBERT JOSE PASCUAL. Suplente: VICIEDO COLONQUES MANUEL.Nombramientos. Mie.Cons.Rec: VICIEDO COLONQUES MANUEL. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 56, S 8, H CS 2048, I/A 98(23.03.16).
04 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GIRONA CASALTA GLORIA;CUBERTORER AYET MANUEL. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 55,S 8, H CS 2048, I/A 97 (20.01.16).
22 de Octubre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: GINER BALLESTER SONIA;USO HERRERO AIDA;TELLOLS BASELGA SILVIA;GOMEZ RUBERTPILAR Datos registrales. T 1652, L 1214, F 55, S 8, H CS 2048, I/A 96 (14.10.15).
05 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: VICENT FERNANDEZ CARMINA;MARIN BERNAT DOLORES. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 55, S8, H CS 2048, I/A 95 (29.09.15).
08 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 55, S 8, H CS 2048, I/A 94 ( 2.07.15).
27 de Abril de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE PARELLADA DURAN ANTONIO;LOSTAO BOYA JUAN;PERELLO GUAL JOAN;PISA LALANAANGEL;URRUTIA GONZALEZ JUAN JOSE;CUBERTORER AYET MANUEL;QUEREDA DEL AGUILA RAFAEL;MARTIN MAQUEDAJULIAN;BOSCH MARTI ANA MARIA;GRACIA DONNAY JAVIER;MARTINEZ GRANADOS JOSE ANTONIO;CARRASCOSA FERRERMARIA AMPARO;BRUNORI IBA脩EZ RAFFAELLO TOMASSO;VILA OLTRA JOSE MANUEL;CARRASCO ACEDO FRANCISCOJOSE;GONZALEZ SANCHEZ JAVIER;ARANEGA MARTINEZ JOSE ENRIQUE;POVEDA ESCRIVA CARLOS;DE LA ROSA DIAZISABEL MARIA;ALONSO RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL;ROSELLO FRIAS VICTORIANO;VANACLOIG PEDROSINMACULADA;GARCIA CARPIO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 53, S 8, H CS 2048, I/A 93 (20.04.15).
14 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Miem.Co.Rec: CANTAVELLA COLONQUES FRANCISCO;CHABRERA MATA ENRIQUE;PITARCH RUBERTMANUEL. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 53, S 8, H CS 2048, I/A 92 ( 7.10.14).
24 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. modificacion articulo 58潞. Modificacion articulo 59.. modificacion articulo 60. modificacion articulo 62.Otros conceptos: Se suprime la disposici贸n adicional segunda. Datos registrales. T 1652, L 1214, F 51, S 8, H CS 2048, I/A 91(12.09.14).
22 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL;CANDAU RAMOS CELINA;SANCHO RUBERT JOSEPASCUAL;BALAGUER MARMANEU JOSE;RAMOS CHABRERA SANTIAGO;VICIEDO COLONQUES MANUEL. Suplente: LLOP USOJOSE;NEBOT GIL TOMAS. Pre.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL. Sec.Cons.Rec: CANDAU RAMOS CELINA.Vcs.Cons.Rec: TORAN MONFERRER CARLOS JOSE. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL.Pre.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL. Mie.Cons.Rec: CANDAU RAMOS CELINA. Sec.Cons.Rec: CANDAU RAMOSCELINA. Mie.Cons.Rec: TORAN MONFERRER CARLOS JOSE;SANCHO RUBERT JOSE PASCUAL;BALAGUER MARMANEUJOSE;RAMOS CHABRERA SANTIAGO. Suplente: VICIEDO COLONQUES MANUEL;LLOP USO JOSE. Vcs.Cons.Rec: TORANMONFERRER CARLOS JOSE. Mie.Cons.Rec: ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE. Vcs.Cons.Rec: ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE.Datos registrales. T 1652, L 1214, F 51, S 8, H CS 2048, I/A 90 (14.08.14).
15 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: CUBERTORER AYET MANUEL. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 161, S 8, H CS 2048, I/A 89 (
27 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Dir. General: TORAN MONFERRER CARLOS JOSE. Nombramientos. Dir. General: CUBERTORER AYETMANUEL. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 159, S 8, H CS 2048, I/A 88 (18.06.14).
07 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: CANTAVELLA AMPOSTA FRANCISCO. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 157, S 8, H CS 2048, I/A 84(25.04.14).
Nombramientos. Apoderado: CANTAVELLA AMPOSTA FRANCISCO. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 157, S 8, H CS 2048,I/A 85 (25.04.14).
Nombramientos. Apoderado: CORONA ADSUARA SALVADOR. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 157, S 8, H CS 2048, I/A 86(25.04.14).
Nombramientos. Apoderado: PORTALES LLOP ENRIC PASQUAL. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 158, S 8, H CS 2048, I/A87 (25.04.14).
12 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: NEBOT CANET ROMAN. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 156, S 8, H CS 2048, I/A 82 ( 5.03.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: NEBOT CANET ROMAN. Datos registrales. T 1638, L 1200, F 156, S 8, H CS 2048, I/A 83 ( 5.03.14).
10 de Febrero de 2014Otros conceptos: Modificados los Estatutos Sociales con la finalidad de establecer un texto homog茅neo para todas las Cajas Ruralesdel Grupo Cooperativo consolidable de entidades de cr茅dito, Cajas Rurales Unidas, Cajamar, distintas de la entidad Cabecera. Datosregistrales. T 1605, L 1167, F 74, S 8, H CS 2048, I/A 81 ( 3.02.14).
10 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apoderado: NEBOT CANET ROMAN. Datos registrales. T 1605, L 1167, F 73, S 8, H CS 2048, I/A 79 ( 3.09.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: NEBOT CANET ROMAN. Datos registrales. T 1605, L 1167, F 73, S 8, H CS 2048, I/A 80 ( 3.09.13).
15 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CUBEDO VICENTE;MARTINEZ CUBEDO VICENTE. Apo.Sol.: MARTINEZ CUBEDOVICENTE. Datos registrales. T 1605, L 1167, F 73, S 8, H CS 2048, I/A 78 ( 9.04.13).
27 de Marzo de 2013Revocaciones. Apoderado: FONT VILAR PEDRO PASCUAL;FONT MONFORT JOSE MANUEL;MIRO SAPORTA JAIME;ROCHERAMEZQUITA MANUEL JOSE;PARRA SAURA PASCUAL;COLONQUES VILAR JUAN VICENTE;MAS PARRA HECTOR. Datosregistrales. T 1605, L 1167, F 71, S 8, H CS 2048, I/A 74 (20.03.13).
Nombramientos. Apoderado: NEBOT CANET ROMAN. Datos registrales. T 1605, L 1167, F 71, S 8, H CS 2048, I/A 75 (20.03.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: VICENT FERNANDEZ CARMINA;CANTAVELLA AMPOSTA FRANCISCO;MARIN BERNATDOLORES;GIL BENAGES ELENA;CARBO DOLZ VICTOR. Datos registrales. T 1605, L 1167, F 72, S 8, H CS 2048, I/A 76(20.03.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: CUBERTORER AYET MANUEL;MIRO CERDA ALBERTO MIGUEL. Datos registrales. T 1605, L 1167,F 72, S 8, H CS 2048, I/A 77 (20.03.13).
25 de Enero de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: CUBERTORER AYET MANUEL;MIRO CERDA ALBERTO MIGUEL. Datos registrales. T 1605, L 1167,F 70, S 8, H CS 2048, I/A 73 (17.01.13).
16 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GARGALLO GOMEZ YOLANDA. Datos registrales. T 1604, L 1166, F 185, S 8, H CS 2048, I/A 70 (6.11.12).
Nombramientos. Apoderado: MAS PARRA HECTOR. Datos registrales. T 1605, L 1167, F 70, S 8, H CS 2048, I/A 71 ( 6.11.12).
Revocaciones. Apoderado: SANZ IBA脩EZ PASCUAL;BONET MEZQUITA PEDRO;BONET MEZQUITA PEDRO;MARTINEZCUBEDO VICENTE. Datos registrales. T 1605, L 1167, F 70, S 8, H CS 2048, I/A 72 ( 6.11.12).
06 de Noviembre de 2012Modificaciones estatutarias. modificacion articulo 14.modificacion articulo 16. Otros conceptos: incorporaci贸n Capitulo VI, quecontendr谩 tres art铆culos, n煤meros 60 a 62, ambos inclusive, referidos " Integraci贸n en el Grupo y R茅gimen Jur铆dico" "Funciones de la
07 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR. Vcp.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUANBAUTISTA SALVADOR. Mie.Cons.Rec: RUBERT NEBOT LLORENC JOAN;CANDAU VILANOVA ANA MARIA. Suplente: GARRIDOHERRERO SAMUEL PASCUAL. Mie.Cons.Rec: PESUDO ARENOS VICENTE;HERRERO MOMPO MARIA REMEDIOS;CORTESCORBATO ENRIQUE. Suplente: ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUANBAUTISTA SALVADOR;CORTES CORBATO ENRIQUE;CANDAU VILANOVA ANA MARIA;HERRERO MOMPO MARIAREMEDIOS;RUBERT NEBOT LLORENC. Vcp.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR. Suplente: GARRIDOHERRERO SAMUEL PASCUAL;ORTELLS MIRAVET JUAN JOSE. Datos registrales. T 1306, L 869, F 185, S 8, H CS 2048, I/A 67(20.07.12).
Ceses/Dimisiones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 1306, L 869, F 186, S 8, H CS 2048, I/A 68 (24.07.12).
13 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CUBEDO VICENTE. Datos registrales. T 1306, L 869, F 184, S 8, H CS 2048, I/A 66 (3.01.12).
01 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENSIBERGRUP SA. Datos registrales. T 1306, L 869, F 184, S 8, H CS 2048, I/A 65 (20.07.11).
10 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: LLOP USO JOSE. Apo.Sol.: LLOP USO JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: PORTALES LLOPENRIC;TORAN MONFERRER CARLOS JOSE. Apoderado: PORTALES LLOP ENRIC. Datos registrales. T 1306, L 869, F 184, S 8,H CS 2048, I/A 64 (25.02.11).
08 de Octubre de 2010Nombramientos. Vcp.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR. Datos registrales. T 1306, L 869, F 184, S 8,H CS 2048, I/A 63 (14.07.10).
26 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: LLOP USO JOSE. Pre.Cons.Rec: LLOP USO JOSE. Mie.Cons.Rec: NEBOT GIL TOMAS.Vcp.Cons.Rec: NEBOT GIL TOMAS. Mie.Cons.Rec: CANDAU RAMOS CELINA. Sec.Cons.Rec: CANDAU RAMOS CELINA.Mie.Cons.Rec: REIG LLORENS RAFAEL;RAMOS CHABRERA SANTIAGO;VICIEDO COLONQUES MANUEL. Suplente: BALAGUERMARMANEU JOSE;SANCHO RUBERT JOSE PASCUAL. Mie.Cons.Rec: BATALLA LLORENS JUAN BAUTISTA SALVADOR.Nombramientos. Mie.Cons.Rec: PORTALES LLOP ENRIC;BALAGUER MARMANEU JOSE;RAMOS CHABRERASANTIAGO;VICIEDO COLONQUES MANUEL. Suplente: LLOP USO JOSE;NEBOT GIL TOMAS. Pre.Cons.Rec: PORTALES LLOPENRIC. Mie.Cons.Rec: CANDAU RAMOS CELINA. Sec.Cons.Rec: CANDAU RAMOS CELINA. Mie.Cons.Rec: SANCHO RUBERTJOSE PASCUAL. Datos registrales. T 1306, L 869, F 184, S 8, H CS 2048, I/A 63 (14.07.10).
16 de Julio de 2010Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1306, L 869, F 184, S 8, H CS2048, I/A 63 ( 8.07.10).
24 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: LLOP USO JOSE;TORAN MONFERRER CARLOS JOSE. Apo.Sol.: TORAN MONFERRER CARLOSJOSE. Datos registrales. T 1306, L 869, F 183, S 8, H CS 2048, I/A 61 (13.02.09).